Actos BORME de Libertad Digital Sa
26 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: PERDIGUERO SANMIGUEL SANTIAGO. Nombramientos. Representan: TEBAS LLANASJAVIER. Datos registrales. T 38564 , F 211, S 8, H M 251639, I/A 62 (19.04.23).
26 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Representan: ALONSO UCEDA MARIA DE LOS ANGELES. Consejero: ANALISIS Y ESTUDIOS INMOBILIARIOS SL. Datosregistrales. T 38564 , F 210, S 8, H M 251639, I/A 61 (19.09.22).
14 de Julio de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.037.240,00 Euros. Desembolsado: 1.037.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.800.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.800.500,00 Euros. Datos registrales. T 38564 , F 207, S 8, H M 251639, I/A 60 ( 7.07.22).
28 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Consejero: LANDALUCE GALBAN EMILIA. Datos registrales. T 38564 , F 207, S 8, H M 251639, I/A 59 (21.09.21).
16 de Septiembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 298.200,00 Euros. Desembolsado: 298.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.763.260,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.763.260,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culo 4 y 13 de los estatutossociales.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.libertaddigital.com/corporativo/. Datosregistrales. T 38564 , F 205, S 8, H M 251639, I/A 58 ( 9.09.21).
01 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: DELGADO MATEO JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: PERDIGUERO SANMIGUELSANTIAGO. Datos registrales. T 38564 , F 204, S 8, H M 251639, I/A 57 (25.05.21).
31 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Datos registrales. T 38564 , F 204, S 8, H M 251639, I/A 56 (23.12.20).
11 de Diciembre de 2020Nombramientos. Consejero: EDUCATION LEADERHISP CONSULTING GROUP SL. Representan: DELGADO MATEO JOSEMARIA. Datos registrales. T 38564 , F 204, S 8, H M 251639, I/A 55 ( 2.12.20).
26 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEREZ LIENDO MARIA NIEVES. Datos registrales. T 38564 , F 203, S 8, H M 251639, I/A 54(19.11.20).
25 de Mayo de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 454.030,00 Euros. Desembolsado: 454.030,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.465.060,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.465.060,00 Euros. Datos registrales. T 38564 , F 201, S 8, H M 251639, I/A 53 (18.05.20).
31 de Octubre de 2019Nombramientos. Ent.Reg.Cont: GVC GAESCO VALORES SV SA. Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORESASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 38564 , F 201, S 8, H M 251639,
21 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Ent.Reg.Cont: BEKA FINANCE SV SA. Reelecciones. Consejero: HERRERO TEJEDOR ALGARLUIS;BRANDAU HEVIA DIETER;SOMALO MARTIN JAVIER;EDIFICIOS GALEM SOCIEDAD LIMITADA;JIMENEZ LOSANTOSFEDERICO. Datos registrales. T 38564 , F 200, S 8, H M 251639, I/A 51 (13.08.19).
05 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 995.920,00 Euros. Desembolsado: 995.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.011.030,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.011.030,00 Euros. Datos registrales. T 20643 , F 224, S 8, H M 251639, I/A 50 (29.01.19).
20 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Datos registrales. T 20643 , F 224, S 8, H M 251639, I/A 49 ( 8.11.18).
19 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RAGA GIL JOSE. Datos registrales. T 20643 , F 224, S 8, H M 251639, I/A 48 (11.06.18).
28 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Consejero: ANALISIS Y ESTUDIOS INMOBILIARIOS SL.Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Representan: ALONSO UCEDA MARIA DE LOS ANGELES. Datosregistrales. T 20643 , F 223, S 8, H M 251639, I/A 47 (20.09.17).
21 de Noviembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 432.670,00 Euros. Desembolsado: 432.670,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.015.110,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.015.110,00 Euros. Datos registrales. T 20643 , F 220, S 8, H M 251639, I/A 46 (10.11.16).
01 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ LIENDO MARIA NIEVES. Apo.Manc.: PEREZ LIENDO MARIA NIEVES. Datos registrales. T20643 , F 219, S 8, H M 251639, I/A 45 (24.08.16).
29 de Agosto de 2016Nombramientos. Consejero: LANDALUCE GALBAN EMILIA. Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 20643 , F 218, S 8, H M 251639, I/A 44 (19.08.16).
02 de Diciembre de 2015Nombramientos. Consejero: LANDALUCE GALBAN EMILIA. Datos registrales. T 20643 , F 218, S 8, H M 251639, I/A 43(24.11.15).
17 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Datos registrales. T 20643 , F 218, S 8, H M 251639, I/A 42 ( 7.08.15).
20 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Consejero: JIMENEZ LOSANTOS FEDERICO;RAGA GIL JOSE. Presidente: JIMENEZ LOSANTOS FEDERICO. Otros conceptos:RATIFICADOS LOS CONSEJEROS NOMBRADOS POR COOPTACION DON LUIS HERRERO-TEJEDOR ALGAR, DON DIETERBRANDAU HEVIA, DON JAVIER SOMALO MARTIN, Y LA ENTIDAD EDIFICIOS GALEM SL. Datos registrales. T 20643 , F 217, S8, H M 251639, I/A 41 (11.11.14).
11 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL MANZANARES CESAR. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MADRID LUIS. Datosregistrales. T 20643 , F 216, S 8, H M 251639, I/A 40 ( 4.03.14).
31 de Octubre de 2013Nombramientos. Consejero: EDIFICIOS GALEM SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GASCO ALEMAN ARTURO. Datosregistrales. T 20643 , F 215, S 8, H M 251639, I/A 39 (21.10.13).
04 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RECARTE GARCIA ANDRADE ALBERTO. Secretario: MORIYON DIEZ CANEDO JAVIER.Consejero: MORIYON DIEZ CANEDO JAVIER;MONTANER SURIS CARLOS ALBERTO;TOLEDANO MARQUES MAURICIO.Revocaciones. Apo.Manc.: RECARTE GARCIA ANDRADE ALBERTO;MORIYON DIEZ CANEDO JAVIER. Nombramientos.Consejero: HERRERO TEJEDOR ALGAR LUIS;BRANDAU HEVIA DIETER;SOMALO MARTIN JAVIER. Secretario: RODRIGUEZMADRID LUIS. Datos registrales. T 20643 , F 215, S 8, H M 251639, I/A 38 (24.09.13).
11 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: BARDERAS NIETO ANTONIO JULIAN. Nombramientos. Representan: ALONSO UCEDA MARIADE LOS ANGELES. Datos registrales. T 20643 , F 214, S 8, H M 251639, I/A 37 ( 3.09.13).
22 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL.Datos registrales. T 20643 , F 214, S 8, H M 251639, I/A 36 (12.07.13).
10 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: NORTHERN INVESTMENTS SA. Representan: BARDERAS NIETO ANTONIO JULIAN.Nombramientos. Representan: BARDERAS NIETO ANTONIO JULIAN. Consejero: TOLEDANO MARQUES MAURICIO;ANALISIS YESTUDIOS INMOBILIARIOS SL. Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Aud.C.Con.: AUDITORES YCENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 20643 , F 213, S 8, H M 251639, I/A 35 (28.09.12).
10 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO. Presidente: CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO.Nombramientos. Presidente: JIMENEZ LOSANTOS FEDERICO. Datos registrales. T 20643 , F 213, S 8, H M 251639, I/A 34(30.07.12).
25 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ LOSANTOSFEDERICO JORGE. Datos registrales. T 20643 , F 212, S 8, H M 251639, I/A 33 (13.07.12).
21 de Mayo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 20643 , F 211, S 8, H M 251639, I/A 32( 7.05.12).
17 de Abril de 2012Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 21& EL PODER OTORGADO A LUIS RODRIGUEZ MARIN,SIENDO LO CORRECTO LUIS RODRIGUEZ MADRID. Datos registrales. T 20643 , F 204, S 8, H M 251639, I/A 21 (12.06.08).
22 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: RECARTE GARCIA ANDRADE ALBERTO. Nombramientos. Presidente: CABRILLO RODRIGUEZFRANCISCO. Datos registrales. T 20643 , F 211, S 8, H M 251639, I/A 31 (10.02.12).
16 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Consejero: VIDAL MANZANARES CESAR. Aud.C.Con.:AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Modificaciones estatutarias. 18. Administraci贸n y Representacion.- 18.Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 20643 , F 210, S 8, H M 251639, I/A 30 ( 2.11.11).
08 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: TOLEDANO MARQUES MAURICIO. Datos registrales. T 20643 , F 210, S 8, H M 251639, I/A 29(29.03.11).
07 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO NAVARRO FRANCISCO JAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO NAVARROFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: BRANDAU HEVIA DIETER;SOMALO MARTIN JAVIER. Datos registrales. T20643 , F 208, S 8, H M 251639, I/A 28 (23.11.10).
31 de Agosto de 2010Reelecciones. Consejero: MONTANER SURIS CARLOS ALBERTO. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datosregistrales. T 20643 , F 208, S 8, H M 251639, I/A 27 (18.08.10).
11 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.291.220,00 Euros. Desembolsado: 1.291.220,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.582.440,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.582.440,00 Euros. Datos registrales. T 20643 , F 206, S 8, H M 251639, I/A 26 (30.11.09).
11 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 20643 , F 206, S 8, H M 251639, I/A 25(30.10.09).
22 de Septiembre de 2009Reelecciones. Consejero: RECARTE GARCIA ANDRADE ALBERTO;JIMENEZ LOSANTOS FEDERICO;RUBIO NAVARROFRANCISCO JAVIER;RAGA GIL JOSE;CABRILLO RODRIGUEZ FRANCISCO. Presidente: RECARTE GARCIA ANDRADEALBERTO. Secretario: MORIYON DIEZ CANEDO JAVIER. Vicepresid.: JIMENEZ LOSANTOS FEDERICO. Consejero: MORIYONDIEZ CANEDO JAVIER. Datos registrales. T 20643 , F 205, S 8, H M 251639, I/A 24 (10.09.09).
20 de Abril de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERRER BONSOMS MILLET JUAN JOSE. Datos registrales. T 20643 , F 205, S 8, H M 251639, I/A23 ( 3.04.09).