Buscador CIF Logo

Actos BORME Licater Inversiones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Licater Inversiones Sl

Actos BORME Licater Inversiones Sl - B84495662

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Licater Inversiones Sl con CIF B84495662

馃敊 Perfil de Licater Inversiones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Licater Inversiones Sl

11 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;OSACAR IBARROLA ALBERTO;DIEZ ARRANZ BEATRIZ;FREIREVILANOVA ANA;CASTA脩ON MARTINEZ ESPERANZA;GARCIA MANZANO OLIVIA. Nombramientos. Apo.Sol.: INTERTRUST(SPAIN) SA. Datos registrales. T 31450 , F 35, S 8, H M 388751, I/A 19 ( 4.10.23).

08 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSACAR IBARROLA ALBERTO. Nombramientos. Consejero: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datosregistrales. T 31450 , F 34, S 8, H M 388751, I/A 18 (27.04.23).

21 de Marzo de 2018
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 - PISO 4 (MADRID). Datos registrales. T 31450 , F 34, S 8, H M 388751, I/A 17(14.03.18).

16 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Vicepresid.: GOMEZ DIEZ ISABEL.Secretario: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ CONTRERAS GONZALO. Consejero:

Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;MOCHALES FORERO PAULA;GOMEZ DIEZISABEL. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZHERNANDEZ PALOMA. Nombramientos. Apoderado: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;OSACAR IBARROLA ALBERTO;DIEZARRANZ BEATRIZ;FREIRE VILANOVA ANA;CASTA脩ON MARTINEZ ESPERANZA;GARCIA MANZANO OLIVIA. Datos registrales.T 31450 , F 32, S 8, H M 388751, I/A 16 ( 8.06.16).

18 de Noviembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.499.745,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.183.287,00 Euros. Datos registrales. T 31450 , F 31, S8, H M 388751, I/A 14 (10.11.15).

06 de Abril de 2015
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: HILLDER SA. Datos registrales. T 31450 , F 31, S 8, H M 388751,I/A 13 (25.03.15).

30 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Datos registrales. T 21820 , F 169, S 8, HM 388751, I/A 12 (20.09.13).

02 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GODFREY ANDREW ABEL. SecreNoConsj: CABRERA LOPEZ GERMAN. VsecrNoConsj: TEJERIZOGONZALEZ PABLO. Presidente: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Nombramientos. Consejero: TAYLOR MARCUS. Presidente:TAYLOR MARCUS. Secretario: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA. Apo.Sol.: CABRERA LOPEZ GERMAN;TEJERIZO GONZALEZPABLO;POMARES BOTANA ROBERTO;AGRAFOJO RAMOS RAFAEL;RUENES MARI脩AS VICTORIA. Modificacionesestatutarias. 17.. Datos registrales. T 21820 , F 169, S 8, H M 388751, I/A 11 (22.08.13).

04 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Datos registrales. T 21820 , F 168, S 8,H M 388751, I/A 10 (26.03.13).

17 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Nombramientos. Consejero:GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL;GODFREY ANDREW ABEL. Presidente: GONZALEZ HERNANDEZPALOMA. Vicepresid.: GOMEZ DIEZ ISABEL. SecreNoConsj: CABRERA LOPEZ GERMAN. VsecrNoConsj: TEJERIZO GONZALEZPABLO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 21820 , F 167, S 8, H M 388751, I/A 8 ( 5.12.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ DIEZ ISABEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZRAQUEL;GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA;HERNANDEZ HERNANDEZ RAQUEL;MOCHALES FORERO PAULA;GOMEZ DIEZISABEL. Datos registrales. T 21820 , F 167, S 8, H M 388751, I/A 9 ( 5.12.12).

13 de Septiembre de 2011
Ampliacion del objeto social. DIRECCION Y GESTION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DEENTIDADES TANTO RESIDENTES COMO NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL QUE DETERMINEN UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DIRECTO O INDIRECTO, IGUAL O SUPERIOR AL 5% MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACIONDE MEDIOS MATERIALES Y PERSON. Datos registrales. T 21820 , F 166, S 8, H M 388751, I/A 7 (31.08.11).

16 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORDOBA FERNANDO EMILIANO. Nombramientos. Adm. Solid.: GONZALEZ HERNANDEZPALOMA;GOMEZ DIEZ ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 21820 , F 166, S 8, H M 388751, I/A 6 ( 3.12.09).

18 de Junio de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.680.536,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.683.542,00 Euros. Datos registrales. T 21820 , F 165, S8, H M 388751, I/A 5 ( 8.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n