Actos BORME de Limpiezas Faro Sl
08 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4304, L 4304, F 30, S 8, H PO 7675, I/A34 (31.08.22).
03 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: CAMANZO GONZALEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 4304, L 4304, F 30, S 8, H PO 7675, I/A 33(24.12.19).
21 de Noviembre de 2019Cambio de objeto social. objeto principal la dedicaci贸n a servicios de limpieza industrial, comercial y dom茅stica, desinfecci贸n ydesinsectaci贸n en general, as铆 como a toda otra clase de productos objeto de comercio legal y a cualquier otra actividad comercial oindustrial l铆cita. Adem谩s: 1. La gesti贸n y ejecuci贸n de centr. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 199, S 8, H PO 7675, I/A 32(15.11.19).
25 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 198, S 8, H PO 7675,I/A 31 (18.01.19).
28 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: YA脩EZ DIAZ MARIA ESTHER. Nombramientos. Apoderado: VIDAL PAZ MANUELA. Datosregistrales. T 1273, L 1273, F 198, S 8, H PO 7675, I/A 30 (21.06.18).
13 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: YA脩EZ DIAZ MARIA ESTHER. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 198, S 8, H PO 7675, I/A 29(28.02.17).
20 de Septiembre de 2016Nombramientos. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 198, S 8, H PO7675, I/A 28 (12.09.16).
12 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.155.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.439.202,00 Euros. Datos registrales. T 1273, L 1273, F197, S 8, H PO 7675, I/A 27 ( 5.02.15).
11 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: CAMANZO GONZALEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 197, S 8, H PO 7675, I/A 26( 3.03.14).
17 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: IGLESIAS SEXTO JOSE LUIS. Aud.Supl.: LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1273,L 1273, F 197, S 8, H PO 7675, I/A 25 ( 9.10.13).
14 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SERRANO FRANCISCO. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 197, S 8, H PO 7675, I/A 24 (4.10.13).
21 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS. Aud.Supl.: SERANTES ARIAS JUAN EMILIO. Datos registrales. T 1273,L 1273, F 196, S 8, H PO 7675, I/A 23 ( 8.11.12).
07 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 199.998,00 Euros. Resultante Suscrito: 283.602,00 Euros. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 196,S 8, H PO 7675, I/A 22 (23.04.12).
16 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ SERRANO FRANCISCO. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 196, S 8, H PO 7675, I/A 21( 3.05.11).
15 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apoderado: CASARES GONZALEZ PAULINO. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 195, S 8, H PO 7675, I/A 19 (1.12.09).
Nombramientos. Apoderado: CASARES GONZALEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1273, L 1273, F 195, S 8, H PO 7675,I/A 20 ( 1.12.09).
20 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS. Aud.Supl.: SERANTES ARIAS JUAN EMILIO. Datos registrales. T1273, L 1273, F 195, S 8, H PO 7675, I/A 18 (10.11.09).