Actos BORME de Linde Hydraulics Iberica Sl
04 de Abril de 2023Cambio de domicilio social. AV VIA AUGUSTA,NUM.15,SANT CUGAT BUSINESS PARK (SANT CUGAT DEL VALLES). Datosregistrales. T 47413 , F 11, S 8, H B 420758, I/A 10 (27.03.23).
07 de Marzo de 2023Revocaciones. ADM.UNICO: LAURENT HOTOME. Nombramientos. ADM.UNICO: MICHELE PIAZZA. Datos registrales. T 47413, F 11, S 8, H B 420758, I/A 8 ( 1.03.23).
Nombramientos. APODERAD.SOL: DEL CASTILLO ALEGRE OLGA;PEREZ SUAREZ JONAY VALENTIN;CARASSO BRILLASJAVIER. Datos registrales. T 47413 , F 11, S 8, H B 420758, I/A 9 ( 1.03.23).
14 de Agosto de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: BONET LOPEZ JOSE FRANCISCO. Nombramientos. ADM.UNICO: LAURENT HOTOME. Datosregistrales. T 47413 , F 11, S 8, H B 420758, I/A 7 ( 5.08.20).
15 de Julio de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;FRUHBECK BORRERO GUILLERMO CAYO;BELLOCARDENES ELENA;LOZANO UCLES LETICIA. Datos registrales. T 43072 , F 140, S 8, H B 420758, I/A 5 ( 7.07.20).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PINTOR LOPEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 43072 , F 140, S 8, H B 420758, I/A 6 (7.07.20).
05 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. CM CAN UBACH NAVE 41 A PG.IND.LES FALLULLES (SANT VICENC DELS HORTS). Datosregistrales. T 43072 , F 140, S 8, H B 420758, I/A 4 (28.03.19).
17 de Diciembre de 2012Nombramientos. APODERADO: THORSTEN ANTHONY EDEMA VAN DER TUUK;FRANK SCHLOSSER;JORG ULRICH. Datosregistrales. T 43072 , F 138, S 8, H B 420758, I/A 3 ( 7.12.12).