Actos BORME de Lineas Y Cables Sa
02 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: MORISON ACPM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 40678 , F 170, S 8, H M 75930, I/A 71 (26.07.22).
21 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ESTEVEZ SANTIAGO REYES-CARLOTA. Nombramientos. Consejero: ESTEVEZ QUINTANAALFONSO;GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Presidente: ESTEVEZ QUINTANA ALFONSO. Vicepresid.: GARCIA DE LAS HERASALFREDO. Datos registrales. T 40678 , F 169, S 8, H M 75930, I/A 70 (14.07.22).
28 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Datos registrales. T 40678 , F 169, S 8, H M 75930, I/A 69(21.04.22).
21 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Presidente: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Datosregistrales. T 40678 , F 169, S 8, H M 75930, I/A 67 (14.01.22).
Revocaciones. Apoderado: BOTELLA MALAGON IGNACIO MANUEL. Datos registrales. T 40678 , F 169, S 8, H M 75930, I/A 68(14.01.22).
15 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Cons.Del.Sol: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Secretario: PINTOBERMUDEZ ALBERTO. Vicepresid.: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Vicesecret.: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Nombramientos.Secretario: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Vicepresid.: ESTEVEZ SANTIAGO REYES-CARLOTA. Vicesecret.: GARCIA HIERNAUXSUSANA-MARIA. Datos registrales. T 40678 , F 168, S 8, H M 75930, I/A 66 ( 5.11.21).
02 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: BARCELO ROMERA ALBERTO. Datos registrales. T 40678 , F 167, S 8, H M 75930, I/A 65 (26.08.21).
01 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LAS HERASALFREDO. Datos registrales. T 40678 , F 166, S 8, H M 75930, I/A 64 (25.05.21).
22 de Abril de 2021Nombramientos. Cons.Del.Sol: ESTEVEZ SANTIAGO REYES-CARLOTA. Datos registrales. T 40678 , F 165, S 8, H M 75930, I/A63 (15.04.21).
04 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. APROBADA LA REDACCION DEL ARTICULO 17 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 40678 , F 165, S 8, H M 75930, I/A 62 (27.11.20).
24 de Agosto de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INTERNACIONAL TECNAIR SA. Datos registrales. T 32735 , F 122, S 8, H M75930, I/A 61 (17.08.20).
04 de Agosto de 2020Nombramientos. Auditor: MORISON ACPM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32735 , F 121, S 8, H M 75930, I/A 60(28.07.20).
21 de Julio de 2020Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 32735 , F 117, S 8, H M75930, I/A 59 (14.07.20).
16 de Julio de 2020Nombramientos. Consejero: GARCIA HIERNAUX SUSANA-MARIA;ABASCAL CARMONA NORBERTO;ESTEVEZ SANTIAGOREYES-CARLOTA. Datos registrales. T 32735 , F 116, S 8, H M 75930, I/A 58 ( 9.07.20).
12 de Junio de 2019Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 55陋 el nombramiento como consejero y consejero delegado de GARCIA DE LAHERAS ALFREDO, siendo lo correcto GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Datos registrales. T 32735 , F 113, S 8, H M 75930, I/A55 (28.05.18).
Nombramientos. Apoderado: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Datos registrales. T 32735 , F 113, S 8, H M 75930, I/A 56 ( 5.06.19).
Nombramientos. Apoderado: BOTELLA MALAGON IGNACIO MANUEL. Datos registrales. T 32735 , F 115, S 8, H M 75930, I/A 57( 5.06.19).
05 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Vicesecret.: HIERNAUX GONZALEZ SUSANA MARIACONSOLACION. Consejero: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Con.Delegado: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Consejero:PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Presidente: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Cons.Del.Sol: PINTO BERMUDEZ ALBERTO.Consejero: HIERNAUX GONZALEZ SUSANA MARIA CONSOLACION. Nombramientos. Consejero: GARCIA DE LA HERASALFREDO. Cons.Del.Sol: GARCIA DE LA HERAS ALFREDO. Presidente: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Consejero: PINTOBERMUDEZ ALBERTO. Cons.Del.Sol: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Secretario: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Consejero: PI脩ARDE JESUS PEDRO. Vicepresid.: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Vicesecret.: PI脩AR DE JESUS PEDRO. Datos registrales. T 32735 , F
13 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: OREJON LOPEZ FERNANDO. Datos registrales. T 32735 , F 113, S 8, H M 75930, I/A 54 ( 5.04.18).
11 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BARCELO ROMERA ALBERTO. Secretario: BARCELO ROMERA ALBERTO. Vicesecret.: PINTOBERMUDEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: HIERNAUX GONZALEZ SUSANA MARIA CONSOLACION. Secretario: PINTOBERMUDEZ ALBERTO. Vicesecret.: HIERNAUX GONZALEZ SUSANA MARIA CONSOLACION. Datos registrales. T 32735 , F 112,S 8, H M 75930, I/A 53 ( 4.04.18).
30 de Noviembre de 2017Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 32735 , F 112, S 8, H M 75930, I/A 52 (23.11.17).
03 de Agosto de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CIJARA INSTALACIONES SL. DUAL INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SA.Datos registrales. T 32735 , F 108, S 8, H M 75930, I/A 51 (26.07.16).
21 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 303.041,00 Euros. Desembolsado: 303.041,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.692.931,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.692.931,00 Euros. Datos registrales. T 32735 , F 107, S 8, H M 75930, I/A 50 (11.12.15).
18 de Diciembre de 2015Ampliacion del objeto social. LA REALIZACION DE PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INGENIERIA, ESTUDIOS, INFORMES,MONTAJES, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, SE脩ALIZACIONES YBALIZAMIENTOS VIALES; FONTANERIA Y SANITARIAS; INSTALACIONES MECANICAS SIN CUALIFICACION ESPECIFICA;INSTALACIONES DE VENTILACION. Datos registrales. T 32735 , F 107, S 8, H M 75930, I/A 49 (10.12.15).
05 de Agosto de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SOTELINK COMUNICACIONES SA. Datos registrales. T 32735 , F 105, S 8, H M75930, I/A 48 (29.07.15).
17 de Noviembre de 2014Ampliacion del objeto social. La confecci贸n de proyectos y estudios y montajes e instalaciones industriales y suministro de materialindustrial. - Mantenimineto de equipos e instalaciones de inform谩tica, telecomunicaci贸n y electricidad en general. - La construcci贸n engeneral, tanto de edificaci贸n como obra civil. - La compra .. Datos registrales. T 32735 , F 104, S 8, H M 75930, I/A 46 ( 6.11.14).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 882.390,00 Euros. Desembolsado: 882.390,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.389.890,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.389.890,00 Euros. Datos registrales. T 32735 , F 104, S 8, H M 75930, I/A 47 ( 6.11.14).
04 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 20534 , F 115, S 8, H M 75930, I/A 45 (28.10.14).
10 de Septiembre de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ELCON ELECTRO ACCESORIOS SA. Datos registrales. T 20534 , F 111, S 8, H M75930, I/A 44 ( 1.09.14).
05 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ JAESURIA JORGE LUIS. Datos registrales. T 20534 , F 110, S 8, H M 75930, I/A 43(21.02.14).
03 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 20534 , F 110, S 8, H M 75930, I/A 42 (26.11.13).
23 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ABASCAL BARQUIN RICARDO. Presidente: ABASCAL BARQUIN RICARDO. Vicesecret.: GARCIADE LAS HERAS ALFREDO. Nombramientos. Consejero: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Presidente: GARCIA DE LAS HERASALFREDO. Vicesecret.: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Cons.Del.Sol: PINTO BERMUDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 20534 , F110, S 8, H M 75930, I/A 41 (15.07.13).
06 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: HIERNAUX ORTEGA MARCELO. Consejero: HIERNAUX ORTEGA MARCELO. Reelecciones.Consejero: ABASCAL BARQUIN RICARDO;BARCELO ROMERA ALBERTO. Secretario: BARCELO ROMERA ALBERTO. Vicesecret.:GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Consejero: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Presidente: ABASCAL BARQUIN RICARDO.Con.Delegado: GARCIA DE LAS HERAS ALFREDO. Datos registrales. T 20534 , F 109, S 8, H M 75930, I/A 40 (30.01.13).
09 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 502.500,00 Euros. Desembolsado: 502.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.507.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.507.500,00 Euros. Datos registrales. T 20534 , F 109, S 8, H M 75930, I/A 39 (24.12.12).
07 de Septiembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 510.000,00 Euros. Desembolsado: 510.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.005.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.005.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 20534 , F 108, S 8, H M 75930, I/A 38 (17.08.12).
10 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ABASCAL BARQUIN RICARDO. Nombramientos. Con.Delegado: GARCIA DE LAS HERASALFREDO. Datos registrales. T 20534 , F 108, S 8, H M 75930, I/A 37 (31.01.12).
28 de Enero de 2011Modificaciones estatutarias. - Modificaci贸n Art. 17. Datos registrales. T 20534 , F 108, S 8, H M 75930, I/A 36 (18.01.11).
20 de Enero de 2011Nombramientos. Auditor: MORISON AC SL. Datos registrales. T 20534 , F 108, S 8, H M 75930, I/A 35 ( 7.01.11).
23 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: MORISON AC SL. Datos registrales. T 20534 , F 107, S 8, H M 75930, I/A 34 (11.12.09).