Buscador CIF Logo

Actos BORME Lledo International School Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Lledo International School Sl

Actos BORME Lledo International School Sl - B12039343

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Castellon para Lledo International School Sl con CIF B12039343

🔙 Perfil de Lledo International School Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Castellon

Actos BORME de Lledo International School Sl

28 de Agosto de 2023
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1776, L 1337, F184, S 8, H CS 27092, I/A 43 (18.08.23).

02 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: GUILLEN PEÑA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1776, L 1337, F 184, S 8, H CS 27092, I/A42 (26.07.23).

20 de Abril de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1776, L 1337, F 184, S 8, H CS 27092, I/A 41 (13.04.23).

02 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUILAR TORRES JUAN. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 183, S 8, H CS 27092, I/A 39(26.07.22).

24 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CURE ARJONA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 117, S 8, H CS 27092, I/A 38(17.02.22).

03 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RODRIGUEZ-INCIARTE CIFUENTES CAROLINA. Nombramientos. Adm. Unico: NUEVO AGORACENTRO DE ESTUDIOS SL. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 116, S 8, H CS 27092, I/A 35 (26.07.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ CAVEDA ISIDORO;HORNEDO NORIEGA IGNACIO;AGUILAR TORRES JUAN. Datosregistrales. T 1752, L 1313, F 116, S 8, H CS 27092, I/A 36 (26.07.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: OLEA COMAS FRANCISCO JAVIER;HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Datos registrales. T 1752, L1313, F 117, S 8, H CS 27092, I/A 37 (26.07.21).

30 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-INCIARTE CIFUENTES CAROLINA. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 115, S 8, HCS 27092, I/A 34 (26.10.20).

19 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NUEVO AGORA CENTRO DE ESTUDIOS SL. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ-INCIARTE CIFUENTES CAROLINA. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 115, S 8, H CS 27092, I/A 32 (12.08.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ ANDION SERGIO RICARDO. Apo.Manc.: GONZALEZ ANDION SERGIO;GONZALEZANDION SERGIO;GONZALEZ ALDAMA AINHOA. Apo.Man.Soli: GONZALEZ ANDION SERGIO RICARDO. Apo.Manc.: GONZALEZALDAMA AINHOA;GONZALEZ ANDION SERGIO. Apo.Man.Soli: DE FARIA-PEREIRA NUNES JOSE LUIS. Apoderado:CARRASCOSA CHAQUES MARIA VICTORIA. Apo.Manc.: GONZALEZ MORCILLO PILAR. Apo.Man.Soli: DE FARIA-PEREIRANUNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1752, L 1313, F 115, S 8, H CS 27092, I/A 33 (12.08.20).

08 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DE LUQUE CRISTINA. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 72, S 8, H CS 27092, I/A 31(23.04.20).

24 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1696, L 1257, F72, S 8, H CS 27092, I/A 30 (15.10.19).

07 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 72, S 8, H CS 27092, I/A 29 (28.02.19).

13 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: CARRASCOSA CHAQUES MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 71, S 8, H CS27092, I/A 27 ( 4.12.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: SISTI TELECHEA BEATRIZ. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 72, S 8, H CS 27092, I/A 28 (4.12.18).

28 de Agosto de 2017
Modificaciones estatutarias. modificacion articulo 7. inclusion articulo 7bis. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 71, S 8, H CS27092, I/A 26 (17.08.17).

12 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: MORENO MONGE EVA. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 71, S 8, H CS 27092, I/A 24 ( 5.04.17).

Nombramientos. Apoderado: MORENO GUTIERREZ PABLO. Datos registrales. T 1696, L 1257, F 71, S 8, H CS 27092, I/A 25 (5.04.17).

15 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLEA COMAS FRANCISCO JAVIER;HORNEDO NORIEGA IGNACIO;GONZALEZ ANDIONSERGIO RICARDO. Datos registrales. T 1691, L 1252, F 121, S 8, H CS 27092, I/A 23 (30.08.16).

30 de Marzo de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1399, L 961, F 28, S 8, H CS 27092, I/A 22 (14.03.16).

31 de Julio de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE FARIA-PEREIRA NUNES JOSE LUIS;HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Datos registrales. T1399, L 961, F 28, S 8, H CS 27092, I/A 19 (22.07.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE FARIA-PEREIRA NUNES JOSE LUIS;GONZALEZ ANDION SERGIO RICARDO. Datosregistrales. T 1399, L 961, F 28, S 8, H CS 27092, I/A 20 (22.07.15).

Nombramientos. Apoderado: MORENO MONGE EVA. Datos registrales. T 1399, L 961, F 28, S 8, H CS 27092, I/A 21 (22.07.15).

01 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: MADRID GIMENEZ LUIS;GARCIA GONZALEZ JESUS;GARCIA GONZALEZ JESUS. Apoderado:GONZALEZ ALDAMA AINHOA;GONZALEZ ALDAMA AINHOA. Datos registrales. T 1399, L 961, F 28, S 8, H CS 27092, I/A 18(25.03.15).

28 de Enero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: SISTI TELECHEA BEATRIZ;GONZALEZ ANDION SERGIO;MADRID GIMENEZ LUIS. Datosregistrales. T 1399, L 961, F 25, S 8, H CS 27092, I/A 14 (16.01.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ ALDAMA AINHOA;HORNEDO NORIEGA IGNACIO;GONZALEZ ANDION SERGIO. Datosregistrales. T 1399, L 961, F 26, S 8, H CS 27092, I/A 15 (16.01.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: MADRID GIMENEZ LUIS;ENSEÑAT COLL JOSE ANTONIO;GONZALEZ ALDAMAAINHOA;HORNEDO NORIEGA IGNACIO;GONZALEZ ANDION SERGIO. Datos registrales. T 1399, L 961, F 26, S 8, H CS 27092,I/A 16 (16.01.15).

16 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1399, L 961, F 25, S 8, H CS 27092, I/A 13 ( 5.12.13).

30 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MORCILLO PILAR;LOPEZ SEGURA JOSE ANTONIO;MADRID GIMENEZ LUIS;LOPEZSEGURA JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: MADRID GIMENEZ LUIS;GARCIA GONZALEZ JESUS;GARCIAGONZALEZ JESUS;GONZALEZ MORCILLO PILAR. Datos registrales. T 1399, L 961, F 24, S 8, H CS 27092, I/A 12 (22.10.12).

12 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1399, L 961, F 24, S 8, H CS 27092, I/A 11 ( 1.07.10).

26 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: CAMACHO DE LA CALLE JOSE ANTONIO;GISBERT PASTOR JOSEFA MARIA. Nombramientos.Apo.Manc.: GONZALEZ MORCILLO PILAR;LOPEZ SEGURA JOSE ANTONIO;MADRID GIMENEZ LUIS;LOPEZ SEGURA JOSEANTONIO. Datos registrales. T 1378, L 941, F 20, S 8, H CS 27092, I/A 9 (17.02.10).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ALDAMA AINHOA. Datos registrales. T 1378, L 941, F 22, S 8, H CS 27092, I/A 10(17.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información