Actos BORME de Llorente & Cuenca America Sl
27 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO;DOMINGUEZ LEANDRO JOSE;JURADO RODRIGUEZ ANA BELEN;VARONA SEGADO MARIADEL CARMEN;PINEDO DE MIGUEL ARTURO;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASIMARIA. Apo.Man.Soli: GARCIA NAVARRETE LUISA;GUISASOLA QUEREJETA MARTA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;ROMERO PANIAGUA ALEJANDRO;PE脩A CANENCIA LUIS MIGUEL;GARCIANAVARRETE LUISA;GUISASOLA QUEREJETA MARTA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Datos registrales. T 41459 , F 8, S 8, H M258779, I/A 30 (17.03.23).
Nombramientos. Apoderado: OCA脩A GONZALEZ JUAN-PABLO. Datos registrales. T 41459 , F 11, S 8, H M 258779, I/A 31(17.03.23).
14 de Marzo de 2022Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LLORENTE & CUENCA SA. Datos registrales. T 41459 , F 8, S 8, H M 258779, I/A29 ( 7.03.22).
04 de Mayo de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.312,31 Euros. Resultante Suscrito: 191.636,27 Euros. Datos registrales. T 41459 , F 5, S 8, H M258779, I/A 28 (26.04.21).
12 de Marzo de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 475,00 Euros. Resultante Suscrito: 173.323,96 Euros. Datos registrales. T 41459 , F 4, S 8, H M258779, I/A 26 ( 5.03.21).
Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE. Nombramientos. Representan: GARCIA NAVARRETELUISA. Datos registrales. T 41459 , F 4, S 8, H M 258779, I/A 27 ( 5.03.21).
15 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;PANADERO ILLERA GREGORIO;GUISASOLA QUEREJETA MARTA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUISASOLA QUEREJETA MARTA. Datos registrales. T 15413 , F 225, S 8, H M 258779, I/A 25 (8.02.21).
27 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA NAVARRETE LUISA. Datos registrales. T 15413 , F 222, S 8, H M 258779, I/A 24(20.08.19).
18 de Diciembre de 2018Modificaciones estatutarias. 5. Capital Social. Transformaci贸n de 432.122 participaciones sociales de la clase c a participacionessociales de la clase P.. Datos registrales. T 15413 , F 222, S 8, H M 258779, I/A 23 (11.12.18).
10 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Apo.Manc.: GONZALEZREGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DE MIGUELARTURO;NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLEROENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DE MIGUEL ARTURO. Nombramientos.Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;PANADERO ILLERA GREGORIO;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;GUISASOLA QUEREJETA MARTA;NAVARROMARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA. Datos registrales. T 15413 , F 219, S 8, H M 258779, I/A 22 ( 2.10.18).
06 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: GONZALEZ REGLEROENRIQUE. Datos registrales. T 15413 , F 218, S 8, H M 258779, I/A 21 (26.02.18).
22 de Agosto de 2016Cambio de objeto social. La Sociedad tiene como objeto la prestaci贸n de servicios de consultor铆a de comunicaci贸n, imagen yrelaciones p煤blicas, lo que incluye la realizaci贸n de todo tipo de actividades en estas 谩reas, tales como: elaboraci贸n y ejecuci贸n deplanes de comunicaci贸n interna y externa para compa帽铆as e institucio. Datos registrales. T 15413 , F 218, S 8, H M 258779, I/A 20(11.08.16).
08 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: PINEDO DE MIGUEL ARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLEROENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASIMARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DELCARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DE MIGUEL ARTURO;NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASIMARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Datos registrales. T 15413 , F 215, S 8, H M 258779, I/A 18 (26.02.16).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DEMIGUEL ARTURO. Datos registrales. T 15413 , F 216, S 8, H M 258779, I/A 19 (26.02.16).
03 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 32.088,00 Euros. Resultante Suscrito: 172.848,66 Euros. Datos registrales. T 15413 , F 214, S 8, HM 258779, I/A 17 (24.02.16).
20 de Junio de 2013Cambio de domicilio social. C/ LAGASCA, NUMERO 88 3潞 (MADRID). Datos registrales. T 15413 , F 213, S 8, H M 258779, I/A 16(12.06.13).
20 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 15413 , F 212, S 8,H M 258779, I/A 14 (11.12.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PINEDO DE MIGUEL ARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLERO
11 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO;DOMINGUEZ LEANDRO JOSE;JURADO RODRIGUEZ ANA BELEN. Datos registrales. T15413 , F 211, S 8, H M 258779, I/A 13 (29.11.12).
02 de Octubre de 2012P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.964,66 Euros. Resultante Suscrito: 140.760,66 Euros.Otros conceptos: MODIFICADO EL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALESY REFUNDICION DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 15413 , F 201, S 8, H M 258779, I/A 12 (21.09.12).
16 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: LLORENTE & CUENCASL. Representan: LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 15413 , F 201, S 8, H M 258779, I/A 11 ( 6.02.12).
10 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CUENCA COT OLGA;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 15413 , F 201, S 8, H M 258779, I/A 10 ( 1.06.11).