Buscador CIF Logo

Actos BORME Llorente & Cuenca Madrid Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Llorente & Cuenca Madrid Sl

Actos BORME Llorente & Cuenca Madrid Sl - B82894122

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Llorente & Cuenca Madrid Sl con CIF B82894122

馃敊 Perfil de Llorente & Cuenca Madrid Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Llorente & Cuenca Madrid Sl

07 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 45012 , F 53, S 8, H M 273715, I/A 55 (29.11.23).

22 de Mayo de 2023
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 588,55 Euros. Resultante Suscrito: 48.297,09Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 828,96 Euros. Resultante Suscrito: 49.126,05 Euros. Datos registrales. T 45012 , F 52, S 8,H M 273715, I/A 54 (12.05.23).

18 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO;DOMINGUEZ LEANDRO JOSE;JURADO RODRIGUEZ ANA BELEN;VARONA SEGADO MARIADEL CARMEN;PINEDO DE MIGUEL ARTURO;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASIMARIA. Apo.Man.Soli: GARCIA NAVARRETE LUISA;GUISASOLA QUEREJETA MARTA;LOPEZ ZAFRA JORGE;CASTILLEROHERANZ JUAN. Nombramientos. Apoderado: PE脩A CANENCIA LUIS MIGUEL;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;ROMEROPANIAGUA ALEJANDRO;LOPEZ ZAFRA JORGE;GARCIA NAVARRETE LUISA;GUISASOLA QUEREJETA MARTA;CASTILLEROHERANZ JUAN. Datos registrales. T 32607 , F 83, S 8, H M 273715, I/A 53 (11.04.23).

24 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: OCA脩A GONZALEZ JUAN-PABLO. Datos registrales. T 32607 , F 82, S 8, H M 273715, I/A 52(16.03.23).

21 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JORGE;CASTILLERO HERANZ JUAN. Datos registrales. T 32607 , F 79, S 8, H M273715, I/A 51 (14.09.22).

19 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: PINEDO DE MIGUEL ARTURO. Nombramientos. Representan: LOPEZ ZAFRA JORGE. Datosregistrales. T 32607 , F 75, S 8, H M 273715, I/A 49 (11.08.22).

Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ESTUDIO LLYC SL. LLORENTE & CUENCA-REPUTACION Y DEPORTE SL. Datosregistrales. T 32607 , F 75, S 8, H M 273715, I/A 50 (11.08.22).

14 de Marzo de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LLORENTE & CUENCA SA. Datos registrales. T 32607 , F 75, S 8, H M 273715,I/A 48 ( 7.03.22).

04 de Mayo de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.719,28 Euros. Resultante Suscrito: 48.885,64 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 73, S 8, H M273715, I/A 47 (26.04.21).

23 de Abril de 2021
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32607 , F 73, S 8, H M 273715, I/A 46 (16.04.21).

17 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;PANADERO ILLERA GREGORIO;GUISASOLA QUEREJETA MARTA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUISASOLA QUEREJETA MARTA. Datos registrales. T 32607 , F 70, S 8, H M 273715, I/A 45(10.02.21).

31 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 69, S 8, H M 273715, I/A 44 (24.03.20).

27 de Diciembre de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: REPUTATION TRAINERS SL. Datos registrales. T 32607 , F 66, S 8, H M 273715,I/A 43 (19.12.19).

14 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 66, S 8, H M 273715, I/A 42 ( 7.11.19).

27 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA NAVARRETE LUISA. Datos registrales. T 32607 , F 63, S 8, H M 273715, I/A 41(20.08.19).

27 de Diciembre de 2018
Modificaciones estatutarias. 5. Capital Social. Transformaci贸n de 80.333 participaciones sociales de la clase C a participacionessociales de la clase P.. Datos registrales. T 32607 , F 63, S 8, H M 273715, I/A 40 (19.12.18).

26 de Diciembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.004,16 Euros. Resultante Suscrito: 40.166,36 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 62, S 8, H M273715, I/A 39 (18.12.18).

24 de Diciembre de 2018
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES AL HABERSE RECTIFICADO LAESCRITURA QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 10陋. Datos registrales. T 32607 , F 62, S 8, H M 273715, I/A 38 (17.12.18).

05 de Noviembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 391,62 Euros. Resultante Suscrito: 39.162,20 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 61, S 8, H M273715, I/A 37 (26.10.18).

09 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZADOLFO;PINEDO DE MIGUEL ARTURO. Apo.Sol.: NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZJUAN. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDODE MIGUEL ARTURO;NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Nombramientos.Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;PANADERO ILLERA GREGORIO;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO;GUISASOLA QUEREJETA MARTA;NAVARROMARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA. Datos registrales. T 32607 , F 58, S 8, H M 273715, I/A 36 (28.09.18).

23 de Marzo de 2018
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 58, S 8, H M 273715, I/A 35 (16.03.18).

27 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: PINEDO DE MIGUELARTURO. Datos registrales. T 32607 , F 58, S 8, H M 273715, I/A 34 (20.02.18).

26 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 57, S 8, H M 273715, I/A 33 (19.10.16).

26 de Agosto de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 387,71 Euros. Resultante Suscrito: 38.770,58 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 57, S 8, H M273715, I/A 32 (17.08.16).

01 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DEMIGUEL ARTURO. Datos registrales. T 32607 , F 53, S 8, H M 273715, I/A 30 (22.02.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Apo.Sol.: PINEDO DE MIGUEL ARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Nombramientos.Apo.Sol.: NAVARRO MARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLEROENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;CORUJO PEREZ ADOLFO;PINEDO DE MIGUEL ARTURO;NAVARROMARTINEZ JOAN;CURA BLASI MARIA;CASTILLERO HERANZ JUAN. Datos registrales. T 32607 , F 55, S 8, H M 273715, I/A 31(22.02.16).

06 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 53, S 8, H M 273715, I/A 29 (29.10.15).

25 de Junio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 575,74 Euros. Resultante Suscrito: 37.807,13 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 575,74 Euros.Resultante Suscrito: 38.382,87 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 52, S 8, H M 273715, I/A 28 (17.06.15).

25 de Mayo de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 507,78 Euros. Resultante Suscrito: 37.231,39 Euros. Datos registrales. T 32607 , F 51, S8, H M 273715, I/A 27 (18.05.15).

05 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32607 , F 51, S 8, H M 273715, I/A 26 (28.10.14).

16 de Septiembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 566,09 Euros. Resultante Suscrito: 35.286,12 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.886,96Euros. Resultante Suscrito: 37.173,08 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 566,09 Euros. Resultante Suscrito: 37.739,17 Euros.Datos registrales. T 16152 , F 225, S 8, H M 273715, I/A 25 ( 8.09.14).

09 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16152 , F 225, S 8, H M 273715, I/A 24 ( 1.10.13).

06 de Septiembre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 347,20 Euros. Resultante Suscrito: 34.199,23 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 520,80 Euros.Resultante Suscrito: 34.720,03 Euros. Datos registrales. T 16152 , F 224, S 8, H M 273715, I/A 23 (28.08.13).

20 de Junio de 2013
Cambio de domicilio social. C/ LAGASCA, NUMERO 88 3潞 (MADRID). Datos registrales. T 16152 , F 224, S 8, H M 273715, I/A 22(12.06.13).

11 de Enero de 2013
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO;DOMINGUEZ LEANDRO JOSE;JURADO RODRIGUEZ ANA BELEN. Datos registrales. T16152 , F 224, S 8, H M 273715, I/A 21 ( 3.01.13).

11 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 16152 , F 222, S 8,H M 273715, I/A 19 (28.11.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ REGLERO ENRIQUE;VARONA SEGADO MARIA DEL CARMEN;PINEDO DE MIGUELARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Apo.Sol.: PINEDO DE MIGUEL ARTURO;CORUJO PEREZ ADOLFO. Datos registrales. T16152 , F 223, S 8, H M 273715, I/A 20 (28.11.12).

03 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.538,90 Euros. Resultante Suscrito: 33.852,03 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social.Refundidos los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 16152 , F 213, S 8, H M 273715, I/A 18(21.09.12).

12 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16152 , F 213, S 8, H M 273715, I/A 17 (28.08.12).

01 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: LLORENTE HERREROJOSE ANTONIO. Adm. Unico: LLORENTE & CUENCA SL. Datos registrales. T 16152 , F 212, S 8, H M 273715, I/A 16 (10.02.12).

01 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: F G H AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16152 , F 212, S 8, H M 273715, I/A 15 (18.11.11).

14 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CUENCA COT OLGA;LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:LLORENTE HERRERO JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoressolidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 16152 , F 212, S 8, H M 273715, I/A 14 ( 2.06.11).

20 de Octubre de 2010
Reelecciones. Auditor: FGH AUDITORES SL. Datos registrales. T 16152 , F 212, S 8, H M 273715, I/A 13 ( 7.10.10).

10 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: FGH AUDITORES SL. Datos registrales. T 16152 , F 212, S 8, H M 273715, I/A 12 (29.01.10).

01 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: ZARZALEJOS NIETO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 16152 , F 211, S 8, H M 273715, I/A 11(21.01.10).

22 de Julio de 2009
Revocaciones. Apoderado: POLO MARTIN JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: ZARZALEJOS NIETO JOSEANTONIO. Datos registrales. T 16152 , F 211, S 8, H M 273715, I/A 10 (10.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n