Actos BORME de Lluch 4 Sl
05 de Agosto de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 519.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.638.156,00 Euros. Datos registrales. T 41628 ,F 24, S 8, H B 153640, I/A 26 (29.07.22).
15 de Enero de 2020Revocaciones. CONSEJERO: CAMPMANY PEREZ MONTSERRAT;COTORRUELO CAMPMANY JAVIER. PRESIDENTE:COTORRUELO CAMPMANY JAVIER. CONSEJERO: COTORRUELO CAMPMANY CARLOS. SECRETARIO: COTORRUELOCAMPMANY CARLOS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: COTORRUELO CAMPMANY JAVIER;COTORRUELO CAMPMANYCARLOS. Datos registrales. T 41628 , F 24, S 8, H B 153640, I/A 25 ( 3.01.20).
12 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.157.156,00 Euros. Datos registrales. T 41628 , F 24, S 8,H B 153640, I/A 24 (31.01.19).
27 de Junio de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 369.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.007.156,00 Euros. Datos registrales. T 41628 , F 23, S 8,H B 153640, I/A 23 (20.06.18).
06 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.996,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.638.156,00 Euros. Datos registrales. T 41628 , F 21, S 8, HB 153640, I/A 22 (26.08.11).
18 de Enero de 2010Nombramientos. APODERADO: COTORRUELO MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 41628 , F 21, S 8, H B 153640, I/A 21 (5.01.10).