Actos BORME de Lm Wind Power Blades -madrid- Sa
11 de Enero de 2016Otros conceptos: Cancelados los asientos de la sociedad y cerrada la hoja registral. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 30833 , F 207, S 8, H M 288554, I/A 46 (28.12.15).
14 de Septiembre de 2015Otros conceptos: Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el art铆culo 231RRM. Datos registrales. T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 45M ( 3.09.15).
04 de Agosto de 2015Reelecciones. Consejero: BALBUENA GOMEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 45(27.07.15).
25 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: MULLER RENE;MULLER RENE. Datos registrales. T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 44(16.03.15).
13 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: NIELSEN FRANK V. Nombramientos. Consejero: BEVAN RICHARD ANDREW. Datos registrales.T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 43 ( 6.08.14).
10 de Abril de 2014Reelecciones. Consejero: HOFFER SOREN. Presidente: HOFFER SOREN. Datos registrales. T 30833 , F 205, S 8, H M 288554,I/A 42 ( 2.04.14).
13 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Cambio de domicilio social. C/ ANABEL SEGURA 11 -CENTRO DE NEGOCIOS ALBATROS, (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 30833 , F 205, S 8, H M 288554, I/A 41 ( 5.08.13).
31 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30833 , F 205, S 8, H M 288554,I/A 40 (24.07.13).
29 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MARTIN ANTOLIN NICOLAS. Secretario: MONTORO COBLES PATRICIA. Vsecr2.NC: CERROPRIETO IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: LLANEZA ALONSO GRACIELA. VsecrNoConsj: CERRO PRIETO IGNACIO.Reelecciones. Consejero: NIELSEN FRANK V.;BALBUENA GOMEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 26178 , F 15, S 8, H M288554, I/A 38 (18.04.13).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ ABASOLO LUISA;STAREY CLAUS PETER;MARTINEZ ABASOLO LUISA;MARTINEZABASOLO LUISA. Apoderado: MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA;RIESGO MARTINEZ FLORENTINO;BERENGUER TORMOALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: CERRO PRIETO IGNACIO;DE MINGO GONZALEZ SUSANA;BURGHARDERIK;LAZARO ALONSO ANTONIO;BALBUENA GOMEZ MIGUEL ANGEL;MULLER RENE;CERRO PRIETO IGNACIO. Datosregistrales. T 26178 , F 16, S 8, H M 288554, I/A 39 (18.04.13).
12 de Marzo de 2013Nombramientos. Vsecr2.NC: CERRO PRIETO IGNACIO. Apo.Sol.: TEJERO SARRION EDUARDO;SUAREZ TRAMONALBERTO;RUIZ MARIN MARTA. Datos registrales. T 26178 , F 15, S 8, H M 288554, I/A 37 ( 4.03.13).
25 de Junio de 2012Otros conceptos: SE MODIFICA EL ARTICULO 51 DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 26178 , F 14, S 8, H M 288554, I/A36 (12.06.12).
20 de Junio de 2012Reelecciones. Consejero: HOFFER SOREN. Presidente: HOFFER SOREN. Datos registrales. T 26178 , F 14, S 8, H M 288554, I/A35 ( 8.06.12).
18 de Junio de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26178 , F 14, S 8, H M 288554, I/A34 ( 6.06.12).
05 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Consejero: NIELSEN FRANK V. Datos registrales. T26178 , F 13, S 8, H M 288554, I/A 33 (23.11.11).
29 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LISLE YATES DOMINIQUE ROBERT. Revocaciones. Apo.Manc.: BLANCO GALLARDOMODESTO CARLOS. Apoderado: BLANCO GALLARDO MODESTO CARLOS. Nombramientos. Consejero: BALBUENA GOMEZMIGUEL ANGEL. Apoderado: RIESGO MARTINEZ FLORENTINO;MULLER RENE;BERENGUER TORMO ALEJANDRO;CERROPRIETO IGNACIO. Datos registrales. T 26178 , F 11, S 8, H M 288554, I/A 32 (17.12.10).
24 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26178 , F 10, S 8, H M 288554, I/A31 (14.06.10).