Actos BORME de Loditrans Sl
30 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDO JUAN VERDU. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3313 , F 152, S8, H MU 95748, I/A 5 (22.12.20).
07 de Julio de 2020Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BELDA Y RICO S.L. Datos registrales. T 3313 , F 152, S 8, H MU 95748, I/A 4(30.06.20).
28 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: GUSTAVO ADOLFO SANZ PRIEGO. Datos registrales. T 3313 , F 152, S 8, H MU 95748, I/A 3(21.04.20).
14 de Mayo de 2018Cambio de domicilio social. AVDA GENERAL PRIMO DE RIVERA N潞 5 (MURCIA). Datos registrales. T 3313 , F 151, S 8, H MU95748, I/A 2 ( 7.05.18).
17 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: AUDIMER AUDIT PARTNERS SL. Datos registrales. T 8443, L 5733, F 217, S 8, H V 113596, I/A 12(10.01.17).
04 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: SEGURA MOYA ANTONIO;PAYA CARBONELL FERNANDO-MARIA. Datos registrales. T 8443, L5733, F 217, S 8, H V 113596, I/A 11 (27.06.16).
22 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: PERIS GINER MILAGROS. Datos registrales. T 8443, L 5733, F 217, S 8, H V 113596, I/A 10 (15.04.15).
30 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: LLORENS PEREZ NADIA;JORDA PASCUAL JUAN RAMON. Datos registrales. T 8443, L 5733, F 216,S 8, H V 113596, I/A 8 (22.12.14).
Revocaciones. Apoderado: BALDO GARCIA JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 8443, L 5733, F 216, S 8, H V 113596, I/A 9(22.12.14).
17 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: SANZ PRIEGO GUSTAVO ADOLFO;PAYA CARBONELL FERNANDO-MARIA;JIMENEZ GONZALEZMARIA DOLORES. Datos registrales. T 8443, L 5733, F 216, S 8, H V 113596, I/A 7 (10.12.14).
24 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: SEGURA MOYA ANTONIO;JUAN VERDU FERNANDO TADEO. Datos registrales. T 8443, L 5733, F216, S 8, H V 113596, I/A 6 (17.11.14).
14 de Agosto de 2014Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 12潞.- ". Datos registrales. T 8443, L 5733, F 215, S 8, H V 113596, I/A 5 ( 7.08.14).