Actos BORME de Logifrio Gestion Frigorifica Sl
27 de Julio de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 17823 , F 222, S 8, H M 307444, I/A 31 (20.07.23).
26 de Julio de 2023Revocaciones. Auditor: AFP AUDIT & CONSULTING SL. Datos registrales. T 17823 , F 222, S 8, H M 307444, I/A 30 (19.07.23).
08 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO ARGUDO VANESSA;GAMBUS SAIZ MARIA LUISA;ARRASTIA GONZALEZ MARIAMONTSERRAT Datos registrales. T 17823 , F 222, S 8, H M 307444, I/A 29 ( 1.04.22).
04 de Abril de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Datos registrales. T 17823 , F 221, S 8, H M 307444, I/A 28 (28.03.22).
12 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHO MOLINS ALBERTO;MARTINEZ PEREZ ROSA TRINIDAD;RODRIGUEZ DOSANTOS
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ PEREZ ROSA. Nombramientos. Adm. Unico: SEQUEIRA FIGUEIREDO VITORMANUEL. Datos registrales. T 17823 , F 219, S 8, H M 307444, I/A 26 (13.10.21).
23 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: PASCUAL ROMERO MANUEL. Datos registrales. T 17823 , F 219, S 8, H M 307444, I/A 25 (17.07.21).
07 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ESPINOSA MARIA JOSE;LUZ COSTA MIGUEL JOAO. Datos registrales. T 17823 , F 218, S8, H M 307444, I/A 24 (29.04.21).
25 de Febrero de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TRANSPORTES GARCIA VILLALOBOS SA. Datos registrales. T 17823 , F 218, S8, H M 307444, I/A 23 (18.02.21).
22 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: AFP AUDIT & CONSULTING SL. Datos registrales. T 17823 , F 218, S 8, H M 307444, I/A 22 (15.02.21).
17 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA VILLALOBOS FERNANDO. Datos registrales. T 17823 , F 217, S 8, H M 307444, I/A 21(10.09.20).
15 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: LEIS PORRAS JOSE FAUSTINO;MARTINEZ PEREZ ROSA. Presidente: MARTINEZ PEREZ ROSA.Consejero: SANCHO MOLINS ALBERTO. Secretario: SANCHO MOLINS ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZPEREZ ROSA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 17823 , F 216, S 8, H M 307444, I/A 20 ( 8.10.19).
30 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: PADRINO MAYO JUAN JOSE;PADRINO MAYO JUAN JOSE. Datos registrales. T 17823 , F 216, S 8,H M 307444, I/A 19 (23.07.18).
23 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: AFP AUDIT & CONSULTING SL. Datos registrales. T 17823 , F 216, S 8, H M 307444, I/A 18 (16.07.18).
29 de Mayo de 2018Cambio de domicilio social. C/ YUNQUE 8 - POLIGONO INDUSTRIAL SAN JOSE DE VALD (LEGANES). Datos registrales. T17823 , F 216, S 8, H M 307444, I/A 17 (22.05.18).
27 de Febrero de 2013Cambio de domicilio social. CL MAQUINARIA 6 8, POL.IND.ANOIA (SANT ESTEVE SESROVIRES). Datos registrales. T 43611 ,F 155, S 8, H B 433532, I/A 16 (18.02.13).
10 de Febrero de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 66.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000,00 Euros. Datos registrales. T 17823 , F 213, S 8, H M 307444, I/A 15 (29.01.10).
19 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: GARCIA VILLALOBOS FERNANDO. Datos registrales. T 17823 , F 212, S 8, H M 307444, I/A 14 (7.01.10).
02 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL ROMERO MANUEL. Secretario: PASCUAL ROMERO MANUEL. Nombramientos.Consejero: SANCHO MOLINS ALBERTO. Secretario: SANCHO MOLINS ALBERTO. Datos registrales. T 17823 , F 212, S 8, H M307444, I/A 13 (21.05.09).