Actos BORME de Logitren Ferroviaria Sa
15 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NAVARRO GONZALEZ ANTONIO JOSE. VsecrNoConsj: SANFELIU GASENT ZENAYDA.Nombramientos. Secretario: PICAZO SENTI PEDRO. Apoderado: CATALAN VENA PEDRO. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. VsecrNoConsj: OMEÑACA MARTINEZ IGNACIO JOSE. Modificacionesestatutarias. Se modifica el artículo 15 de los estatutos relativo a la forma de la convocatoria de las juntas.. Cambio dedenominación social. CSP LOGITREN SA. Cambio de domicilio social. C/ MENORCA 19 (VALENCIA). Datos registrales. T11171, L 8449, F 21, S 8, H V 123111, I/A 42 ( 8.09.22).
30 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: CATALAN VENA PEDRO. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 21, S 8, H V 123111, I/A 41 (23.06.22).
06 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: QIN LONG. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 139, S 8, H V 123111, I/A 30 (30.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: CHAN HANG. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 10, S 8, H V 123111, I/A 31 (30.05.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: REN HAIJUN. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 12, S 8, H V 123111, I/A 32 (30.05.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA GUTIERREZ ELIAS. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 13, S 8, H V 123111, I/A 33(30.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: TAMARIT SERRANO LUCIA. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 15, S 8, H V 123111, I/A 34(30.05.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: CATALAN VENA PEDRO LUIS. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 15, S 8, H V 123111, I/A 35(30.05.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: URRECHA SARRIA IÑIGO. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 17, S 8, H V 123111, I/A 36(30.05.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: ORTI LLATAS JUAN. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 18, S 8, H V 123111, I/A 37 (30.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: CANO DE MIGUEL MIGUEL. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 19, S 8, H V 123111, I/A 38(30.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE LA LLAVE JAVIER. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 20, S 8, H V 123111, I/A 39
Nombramientos. Apo.Manc.: PARDO BRULL SALVADOR. Datos registrales. T 11171, L 8449, F 21, S 8, H V 123111, I/A 40(30.05.22).
04 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Presidente: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Consejero:FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Vicepresid.: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.Consejero: CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Nombramientos. Consejero: COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALSSL;COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING SL;CSP IBERIAN VALENCIA TERMINAL SOCIEDAD ANONIMA;CATALANAZNAR PEDRO LUIS;CAMARA GIL JUAN FRANCISCO;FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Presidente: COSCOSHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS SL. Otros conceptos: Modificados y refundidos los estatutos sociales en un nuevo texto.Designado D. Elias García Gutiérrez como persona física representante de "COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS, S.L." lacual ha sido nombrada consejera de "LOGITREN FERROVIARIA SA" Designado D. Hang Chan como persona física representante dela entidad "COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING, S.L." la cual ha sido nombrada consejera de "LOGITREN FERROVIARIASA"Designado D. Juan Ortí Llatas como persona física representante de "CSP IBERIAN VALENCIA TERMINAL, S.A.", la cual ha sidonombrada consejera de "LOGITREN FERROVIARIA SA" Designada Dña. María Anais Menguzzato García como persona físicarepresentante de "FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA", la cual ha sido nombrada consejera de "LOGITRENFERROVIARIA SA". Cambio de domicilio social. AVDA BLASCO IBAÑEZ 18 1 (VALENCIA). Cambio de objeto social. Se amplíael objeto social a "La cesión o subarriendo de sus medios (locomotoras, vagones u otros bienes) a tercerosu". Datos registrales. T10824, L 8103, F 135, S 8, H V 123111, I/A 29 (26.04.22).
04 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LLIN CERDA KALIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANFELIU GASENT ZENAYDA. Datosregistrales. T 10824, L 8103, F 135, S 8, H V 123111, I/A 28 (25.02.22).
04 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LAUMAR CARGO SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Designada Dña. María AnaisMenguzzato García, -en sustitución de D. Emilio Bayarri Roca-, como persona física representante de FERROCARRILS DE LAGENERALITAT VALENCIANA, en el consejo de administración de LOGITREN FERROVIARIA SA. Datos registrales. T 10824, L8103, F 134, S 8, H V 123111, I/A 26 (28.01.22).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OCHOA ARRIBAS CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: NAVARRO GONZALEZANTONIO JOSE. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 134, S 8, H V 123111, I/A 27 (28.01.22).
12 de Febrero de 2021Ampliación de capital. Suscrito: 163.440,00 Euros. Desembolsado: 163.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 683.550,00 Euros.Resultante Desembolsado: 683.550,00 Euros. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 133, S 8, H V 123111, I/A 25 ( 5.02.21).
14 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRUAÑES GARCIA RAFAEL. VsecrNoConsj: OCHOA ARRIBAS CARLOS. Nombramientos.SecreNoConsj: OCHOA ARRIBAS CARLOS. VsecrNoConsj: LLIN CERDA KALIA. Datos registrales. T 10824, L 8103, F 133, S 8, HV 123111, I/A 24 ( 2.12.20).
Otros conceptos: Se nombra en fecha 16/12/2019, como persona física representante del Consejero-Vicepresidente de la Sociedadde esta Hoja, la entidad "FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA" a Don Emilio Bayarri Roca, en sustitución de DonJuan Andres Sanchez Jordan.- Datos registrales. T 10824, L 8103, F 133, S 8, H V 123111, I/A 21 M ( 2.12.20).
17 de Julio de 2020Reducción de capital. Importe reducción: 540.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 405.300,00 Euros. Ampliación de capital.Suscrito: 114.810,00 Euros. Desembolsado: 114.810,00 Euros. Resultante Suscrito: 520.110,00 Euros. Resultante Desembolsado:520.110,00 Euros. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 199, S 8, H V 123111, I/A 23 (10.07.20).
09 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: LAUMAR CARGO SOCIEDAD LIMITADA;CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Reelecciones.Consejero: CATALAN AZNAR PEDRO LUIS;LAUMAR CARGO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 199, S8, H V 123111, I/A 22 ( 3.05.19).
19 de Abril de 2018Nombramientos. VsecrNoConsj: OCHOA ARRIBAS CARLOS. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 199, S 8, H V 123111, I/A 20(12.04.18).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA;CAMARA GIL JUAN FRANCISCO.Reelecciones. Consejero: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Presidente: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Consejero:FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Vicepresid.: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Otrosconceptos: DON JUAN ANDRES SANCHEZ JORDAN CON DNI 73992655E HA SIDO DESIGNADO PERSONA FISICAREPRESENTANTE DE "FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA" EN EL CARGO DE CONSEJERO DE LAMERCANTIL "LOGITREN FERROVIARIA SA". Datos registrales. T 9415, L 6697, F 199, S 8, H V 123111, I/A 21 (12.04.18).
30 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: CATALAN VENA PEDRO. Nombramientos. Apoderado: CATALAN VENA PEDRO. Datos registrales.T 9415, L 6697, F 196, S 8, H V 123111, I/A 19 (23.05.16).
29 de Diciembre de 2015Otros conceptos: La consejera "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana" ha sustituido a su persona fisica por don Angel Garcia de laBandera. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 192, S 8, H V 123111, I/A 11 M (21.12.15).
Revocaciones. Apoderado: ATIENZAR GOMEZ YOLANDA. Nombramientos. Apoderado: CATALAN VENA PEDRO. Datosregistrales. T 9415, L 6697, F 194, S 8, H V 123111, I/A 18 (21.12.15).
19 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: LOPEZ SANJOSE MILAGROS. Nombramientos. SecreNoConsj: CRUAÑES GARCIA RAFAEL.Datos registrales. T 9415, L 6697, F 192, S 8, H V 123111, I/A 17 ( 9.08.13).
05 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.D.Gral.: VELGE PATRICK. Nombramientos. Consejero: LAUMAR CARGO SOCIEDAD LIMITADA. Apoderado:ATIENZAR GOMEZ YOLANDA. Cons.Del.Man: LAUMAR CARGO SOCIEDAD LIMITADA. Ampliación de capital. Suscrito:400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.351.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:1.351.000,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 405.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 945.700,00 Euros.Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8º. Acciones. . Datos registrales. T 9415, L 6697, F 192, S 8, H V 123111, I/A 16(29.01.13).
21 de Diciembre de 2012Otros conceptos: D& Maria Luisa Gracia Giménez, que fue designado persona física representante de FERROCARRILS DE LAGENERALITAT VALENCIANA -FGV-, ha sido sustituido por D. PABLO COTINO MULET, en escritura de 30/11/12 por el Notario deValencia D. Eduardo Lluna Aparisi, número 1.334 de protocolo. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 191, S 8, H V 123111, I/A 11 M(14.12.12).
14 de Junio de 2012Nombramientos. Vicepresid.: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 192, S8, H V 123111, I/A 14 ( 5.06.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. Cons.Del.Man: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. Nombramientos.Consejero: CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Cons.Del.Man: CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Datos registrales. T 9415, L 6697, F192, S 8, H V 123111, I/A 15 ( 5.06.12).
11 de Junio de 2012Reducción de capital. Importe reducción: 298.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 501.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Modificación de los artículos 7º y 8º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 191, S 8, H V 123111, I/A 12(31.05.12).
Ampliación de capital. Suscrito: 450.000,00 Euros. Desembolsado: 450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 951.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 951.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 7º y 8º de los estatutossociales. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 191, S 8, H V 123111, I/A 13 (31.05.12).
11 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA. Consejero: GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA.Nombramientos. Consejero: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Cons.Del.Man: FERROCARRILS DE LAGENERALITAT VALENCIANA. Otros conceptos: Doña Maria Luisa Gracia Gimenez, con DNI 17.152.922-M, ha sido designadapersona física representante de la entidad "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana", consejera de la entidad "LOGITRENFERROVIARIA SA". Datos registrales. T 9415, L 6697, F 190, S 8, H V 123111, I/A 11 (29.03.12).
21 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA;CAMARA GIL JUAN FRANCISCO;FERROCARRILS DE LAGENERALITAT VALENCIANA;PEREZ BEATO COS MANUEL;TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA;GRACIA GIMENEZ MARIALUISA. Presidente: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Cons.Del.Man: GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA. Vicepresid.: PEREZ BEATOCOS MANUEL. Cons.Del.Man: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA;CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Secretario: TORRESCAMARA YCIA DE OBRAS SA;GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA. Nombramientos. Consejero: GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA;CAMARAGIL JUAN FRANCISCO;VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. Auditor: BDO AUDITORES SL. Presidente: CAMARA GIL JUANFRANCISCO. Secretario: GRACIA GIMENEZ MARIA LUISA. Cons.Del.Man: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO;GRACIA GIMENEZMARIA LUISA;VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. Secretario: LOPEZ SANJOSE MILAGROS. Ampliación de capital. Suscrito:499.800,00 Euros. Desembolsado: 499.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 799.800,00 Euros. Resultante Desembolsado: 799.800,00Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8º. ACCIONES. El capital social está representadopor siete mil novecientasnoventa y ocho acciones nominativas de cien euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la número uno a lasiete mil novecientas noventa y ocho, ambos inclusive. Dichas acciones se hallan. Otros conceptos: La mercantil "Vias yConstrucciones, S.A.", nombrada consejera ha designado como persona fisica a don Jose Ignacio Legorburo Escobar. Datosregistrales. T 8715, L 6002, F 182, S 8, H V 123111, I/A 9 ( 9.03.12).
Nombramientos. Auditor: FIDES AUDITORES SL. Datos registrales. T 9415, L 6697, F 190, S 8, H V 123111, I/A 10 ( 9.03.12).
29 de Diciembre de 2010Nombramientos. Secretario: TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA. Datos registrales. T 8715, L 6002, F 182, S 8, H V 123111,I/A 8 (20.12.10).
12 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PICAZO SENTI PEDRO. Datos registrales. T 8715, L 6002, F 182, S 8, H V 123111, I/A 7 (2.11.09).
11 de Agosto de 2009Cambio de domicilio social. AVDA DEL PUERTO 332 (VALENCIA). Datos registrales. T 8715, L 6002, F 181, S 8, H V 123111, I/A6 (31.07.09).
12 de Mayo de 2009Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Presidente:CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Consejero: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO;CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Cons.Del.Sol:CATALAN AZNAR PEDRO LUIS. Consejero: PEIRO LLOPIS JOSE RAMON. Cons.Del.Sol: PEIRO LLOPIS JOSE RAMON.Nombramientos. Consejero: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA;CAMARA GIL JUAN FRANCISCO;FERROCARRILS DE LAGENERALITAT VALENCIANA;PEREZ BEATO COS MANUEL;TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA;GRACIA GIMENEZ MARIALUISA. Apod.D.Gral.: VELGE PATRICK. Presidente: CAMARA GIL JUAN FRANCISCO. Cons.Del.Man: GRACIA GIMENEZ MARIALUISA. Vicepresid.: PEREZ BEATO COS MANUEL. Cons.Del.Man: VIAS Y CONSTRUCCIONES SA;CAMARA GIL JUANFRANCISCO. Datos registrales. T 8715, L 6002, F 181, S 8, H V 123111, I/A 5 (30.04.09).