Actos BORME de Luis Martinez Benito Sa
30 de Noviembre de 2017Nombramientos. Auditor: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP. Aud.C.Con.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP. Datosregistrales. T 638 , F 60, S 8, H LO 2100, I/A 40 (22.11.17).
30 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Datos registrales. T 638 , F 59, S 8, H LO 2100, I/A 39 (20.03.17).
03 de Agosto de 2016Ampliacion del objeto social. h).- La prestaci贸n de asistencia financiera y garant铆as en favor de otras sociedades en las que participemayoritariamente. No obstante, la sociedad no desarrollar谩 ninguna actividad para la que las leyes exijan licencias o condiciones, entanto no d茅 cumplimiento exacto a las mismas. Datos registrales. T 638 , F 59, S 8, H LO 2100, I/A 38 (26.07.16).
01 de Diciembre de 2015Nombramientos. Aud.C.Con.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 638 , F 59, S 8, H LO 2100, I/A 37(24.11.15).
19 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: CASTILLO SOLA OSCAR. Datos registrales. T 638 , F 59, S 8, H LO 2100, I/A 36 ( 5.06.15).
27 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO. Presidente: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO.Consejero: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Secretario: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Consejero: MARTINEZ VILLOSLADAALBERTO;MARTINEZ VILLOSLADA JUSTO. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO;MARTINEZ VILLOSLADALUIS. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO. Modificaciones estatutarias. Modificados losart铆culos 8潞, 9潞, 10潞, 11潞 y 13潞 de los Estatutos sociales. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 638 , F 58, S 8, H LO 2100, I/A 35 (13.04.15).
26 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 638 , F 58, S 8, H LO 2100, I/A 34(19.02.14).
30 de Julio de 2013Cambio de domicilio social. PLAZA MAESTRO ARROYO 2 BAJO (CALAHORRA). Datos registrales. T 638 , F 58, S 8, H LO2100, I/A 33 (23.07.13).
25 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: LOSA MARTINEZ JOSE ESTEBAN. Datos registrales. T 638 , F 58, S 8, H LO 2100, I/A 32 (16.05.12).
19 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO;MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Nombramientos.Cons.Del.Sol: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO;MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Reelecciones. Consejero: MARTINEZVILLOSLADA JOSE IGNACIO. Presidente: MARTINEZ VILLOSLADA JOSE IGNACIO. Consejero: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS.Secretario: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Consejero: MARTINEZ VILLOSLADA ALBERTO;MARTINEZ VILLOSLADA JUSTO. Datosregistrales. T 638 , F 57, S 8, H LO 2100, I/A 31 ( 8.08.11).
27 de Abril de 2011Ampliacion del objeto social. La sociedad tiene por objeto: a).- La construcci贸n de viviendas de protecci贸n oficial en sus diversasmodalidades, y aquellas operaciones con ello relacionadas, como adquisici贸n de terrenos, su urbanizaci贸n y parcelaci贸n, uso,arrendamiento y venta de las mismas, someti茅ndose a las disposiciones dic. Datos registrales. T 638 , F 57, S 8, H LO 2100, I/A 30(14.04.11).
11 de Marzo de 2011Nombramientos. Aud.C.Con.: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 638 , F 57, S 8, H LO 2100, I/A 29 ( 2.03.11).
04 de Febrero de 2011Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL. Nombramientos. Auditor: DAC AUDITORESCONSULTORES SLP. Aud.C.Con.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 638 , F 57, S 8, H LO 2100, I/A 28(26.01.11).
10 de Noviembre de 2010Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO 2100, I/A 27 (28.10.10).
14 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VILLOSLADA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO 2100, I/A 26 (3.07.10).
14 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. C/ TORRECILLA EN CAMEROS 1 BAJO (LOGRO脩O). Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO2100, I/A 25 ( 3.06.10).
31 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO 2100, I/A 24 (19.12.09).
13 de Febrero de 2009Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13潞.- La remuneraci贸n de los miembros del Consejode Administraci贸n consistir谩 en unaparticipaci贸n del diez por ciento en los beneficios anuales netos de la sociedad, con las limitaciones que al efecto establece la Ley, ycon aplicaci贸n del art铆culo 130 de la misma. La distribuci贸n entre. Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO 2100, I/A 23 ( 4.02.09).
26 de Enero de 2009Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ VILLOSLADA LUIS. Datos registrales. T 638 , F 56, S 8, H LO 2100, I/A 22 (15.01.09).