Actos BORME de Lumileds Luxeon De Iberia Sl
30 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: RSM SPAINAUDITORES SLP. Datos registrales. T 41407 , F 211, S 8, H M 589032, I/A 22 (23.01.23).
25 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLOGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN. Apo.Man.Soli: SOLOGUREN SANCHEZ-FERRAGUTJUAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRAN THI DIEU ANH;KANIA ARKADIUSZ;CASTELLANOS MARCO ANTONIO;RUSTMAARTEN;JIMENEZ SEGURA JORGE;MARTIN RUIZ-MOYANO ANA BELEN. Datos registrales. T 41407 , F 210, S 8, H M 589032,I/A 21 (18.03.22).
16 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32722 , F 158, S 8, H M 589032,I/A 18 ( 9.02.21).
02 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ SEGURA JORGE. Datos registrales. T 32722 , F 157, S 8, H M 589032, I/A 15 (26.05.20).
21 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEMAN CUBILLO CARLOS. VsecrNoConsj: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO. Consejero:ZIMMER STEVEN ALEXANDER;CLIFFORD MARK EDWARD. Vicepresid.: ZIMMER STEVEN ALEXANDER. Nombramientos. Adm.Mancom.: JIMENEZ SEGURA JORGE;SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 32722 , F 156, S 8, H M 589032,I/A 13 (14.01.20).
16 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: SOLOGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN. Consejero: SOLOGUREN SANCHEZ-FERRAGUTJUAN. Datos registrales. T 32722 , F 156, S 8, H M 589032, I/A 12 ( 9.10.19).
29 de Enero de 2019Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 4陋 EL PODER (2 VECES) A SOLGUREN SANCHEZ-FERRAGUTJUAN, SIENDO LO CORRECTO UNA DE LA VECES A JIMENEZ SEGURA JORGE. ACLARAR QUE EL APELLIDO CORRECTO ESSOLOGUREN Y NO SOLGUREN. Datos registrales. T 32722 , F 152, S 8, H M 589032, I/A 4 ( 2.03.15).
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LAS INSCRIPCIONES 6陋 Y 9陋 EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO YPRESIDENTE DE SOLGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN, SIENDO LO CORRECTO SOLOGUREN SANCHEZ-FERRAGUTJUAN. Datos registrales. T 32722 , F 154, S 8, H M 589032, I/A 6 (10.08.15).
01 de Marzo de 2018Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 32722 , F 156, S 8, H M 589032, I/A 11 (22.02.18).
13 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 32722 , F 156, S 8, H M 589032, I/A 10 ( 6.07.17).
09 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DEL CASTILLO MANIBOG FEDERICO-GERMAN. Consejero: SANABRIA LUENGO JUAN
11 de Julio de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LUMILEDS HOLDING BV. Datos registrales. T 32722 , F 155, S 8,H M 589032, I/A 8 ( 1.07.16).
12 de Abril de 2016Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 141 - EDIFICIO CUZCO IV (MADRID). Datos registrales. T 32722 , F155, S 8, H M 589032, I/A 7 (31.03.16).
17 de Agosto de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 97.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 32722 , F 153, S 8, HM 589032, I/A 5 (10.08.15).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DEL CASTILLO MANIBOG FEDERICO-GERMAN. Consejero: URIARTE VILLALONGAALVARO;MATAIX ALDEANUEVA EDUARDO. Secretario: MATAIX ALDEANUEVA EDUARDO. Revocaciones. Apo.Man.Soli:GARCIA ANIDO ANTONIO;TORRE GARCIA-SOTO JOSE MANUEL;PERALES DIAZ JUSTO;SOLOGUREN SANCHEZ FERRAGUTJUAN. Nombramientos. Consejero: SOLGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN. SecreNoConsj: DEL CASTILLO MANIBOGFEDERICO-GERMAN. Datos registrales. T 32722 , F 154, S 8, H M 589032, I/A 6 (10.08.15).
09 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN;SOLGUREN SANCHEZ-FERRAGUT JUAN;MARTINRUIZ-MOYANO ANA BELEN. Datos registrales. T 32722 , F 152, S 8, H M 589032, I/A 4 ( 2.03.15).
12 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: SOLOGUREN SANCHEZ FERRAGUT JUAN. Apo.Man.Soli: GARCIA ANIDO ANTONIO;TORREGARCIA-SOTO JOSE MANUEL;PERALES DIAZ JUSTO;SOLOGUREN SANCHEZ FERRAGUT JUAN. Datos registrales. T 32722 ,F 151, S 8, H M 589032, I/A 3 ( 4.02.15).
30 de Octubre de 2014Nombramientos. Presidente: SANABRIA LUENGO JUAN ANTONIO. Vicepresid.: TORRE GARCIA-SOTO JOSE MANUEL.Secretario: MATAIX ALDEANUEVA EDUARDO. VsecrNoConsj: DEL CASTILLO MANIBOG FEDERICO-GERMAN. Datos registrales.T 32722 , F 150, S 8, H M 589032, I/A 2 (22.10.14).
27 de Octubre de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.10.14. Objeto social: (i) La comercializaci贸n de todo tipo de productos y equipos,incluyendo sus elementos integrantes, componentes, semi-productos y materias primas correspondientes, en toda su variedad yextensi贸n, en el campo del alumbrado e iluminaci贸n de tecnolog铆a LED, as铆 como la prestaci贸n de servicios... Domicilio: C/ MARIA DEPORTUGAL - 1 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: KONINKLIJKE PHILIPS NV.Nombramientos. Consejero: SANABRIA LUENGO JUAN ANTONIO;TORRE GARCIA-SOTO JOSE MANUEL;URIARTEVILLALONGA ALVARO;MATAIX ALDEANUEVA EDUARDO. Datos registrales. T 32722 , F 149, S 8, H M 589032, I/A 1 (17.10.14).