Actos BORME de Lunia Madrid Norte Sl
26 de Enero de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 34169 , F 1, S 8, H M 524090, I/A 11 (18.01.18).
15 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SURET NICOLAS PIERRE ANDRE. Nombramientos. Consejero: MOISSET ARNAUD. Datosregistrales. T 34169 , F 1, S 8, H M 524090, I/A 10 ( 8.03.17).
20 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE RAMON GARCIA RICARDO. Presidente: DE RAMON GARCIA RICARDO. Con.Delegado: DERAMON GARCIA RICARDO. Nombramientos. Consejero: SCOTTI GIANNI. Presidente: SCOTTI GIANNI. Cambio de domiciliosocial. C/ INDUSTRIAS 4 BAJO 12 (ALCORCON). Datos registrales. T 34169 , F 1, S 8, H M 524090, I/A 9 ( 8.06.16).
17 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: RUI MACHADO DOS SANTOS AMANDIO. Datos registrales. T 29108 , F 44, S 8, H M 524090, I/A 8(10.12.15).
16 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: AMBIT LEMUS RAUL. Presidente: AMBIT LEMUS RAUL. Consejero: SANCHEZ VETAS IVAN.Secretario: SANCHEZ VETAS IVAN. Consejero: MUGICA ACHALANDABASO ANDRES. Revocaciones. Apo.Sol.: AMBIT LEMUSRAUL. Nombramientos. Consejero: DE RAMON GARCIA RICARDO;FERREIRA NUNES LICINIO GILBERTO;SURET NICOLASPIERRE ANDRE. Presidente: DE RAMON GARCIA RICARDO. Con.Delegado: DE RAMON GARCIA RICARDO. SecreNoConsj: PALACASTELLA GABRIEL. Apo.Sol.: PALA CASTELLA GABRIEL;GARCIA SANZ RICARDO. Datos registrales. T 29108 , F 43, S 8, H M524090, I/A 7 ( 9.12.15).
29 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ NOGAL DAVID;RIBERAS MERA JUAN MARIA. Cons.Del.Man: MARTINEZ NOGALDAVID. Secretario: MARTINEZ NOGAL DAVID. Consejero: MARTINEZ NOGAL ANTONIO. Cons.Del.Man: AMBIT LEMUS RAUL.Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ NOGAL DAVID. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ VETAS IVAN. Secretario: SANCHEZVETAS IVAN. Consejero: MUGICA ACHALANDABASO ANDRES. Datos registrales. T 29108 , F 42, S 8, H M 524090, I/A 6(21.09.15).
15 de Julio de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.350,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.350,00 Euros. Datos registrales. T 29108 , F 41, S 8, H M524090, I/A 5 ( 4.07.14).
24 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ALOCEN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ NOGAL ANTONIO.Datos registrales. T 29108 , F 41, S 8, H M 524090, I/A 4 (17.10.13).
01 de Septiembre de 2011Nombramientos. Presidente: AMBIT LEMUS RAUL. Cons.Del.Man: MARTINEZ NOGAL DAVID;AMBIT LEMUS RAUL. Secretario:MARTINEZ NOGAL DAVID. Apo.Sol.: AMBIT LEMUS RAUL;MARTINEZ NOGAL DAVID. Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.000,00Euros. Resultante Suscrito: 30.000,00 Euros. Datos registrales. T 29108 , F 38, S 8, H M 524090, I/A 2 (17.08.11).
Modificaciones estatutarias. QUEDAN MODIFICADOS LOS ARTICULOS 7, 8 Y 13 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.-. Datosregistrales. T 29108 , F 40, S 8, H M 524090, I/A 3 (17.08.11).
29 de Agosto de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.04.11. Objeto social: LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OPERACIONESRELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CRISTALERIA PARA AUTOMOVILES Y DE TODOS AQUELLOS RESPUESTOS YACCESORIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE CRISTALERIA DEL AUTOMOVIL. Domicilio: C/ MARQUES DE LAVALDAVIA 57 (ALCOBENDAS). Capital: 15.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LUNARED SL.Nombramientos. Consejero: AMBIT LEMUS RAUL;MARTINEZ NOGAL DAVID;RIBERAS MERA JUAN MARIA;MARTINEZ ALOCENANTONIO. Datos registrales. T 29108 , F 37, S 8, H M 524090, I/A 1 (17.08.11).