Actos BORME de Luzdeaqui Sa
16 de Enero de 2018Extinción. Datos registrales. T 678, L 469, F 220, S 8, H BU 13792, I/A 13 (10.01.18).
24 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PARA ISMAEL. Cons.Del.Man: MARTIN PARA ISMAEL. Datos registrales. T 678, L 469, F219, S 8, H BU 13792, I/A 11 (17.12.15).
22 de Abril de 2015Otros conceptos: El Consejo de 13/3/2015, modifica la actuación de los Consejeros Delegados Mancomunados,estableciendolo porcuantías; y para los Sres.Peña Herrero,García Gonzalez, Martínez Gutierrez, y Castrillo Iglesias también solidarias. Datos registrales.T 678, L 469, F 219, S 8, H BU 13792, I/A 10 (16.04.15).
14 de Abril de 2015Nombramientos. Cons.Del.Man: PEÑA HERRERO JUAN CARLOS;MARTINEZ GUTIERREZ ANGEL JOSE;PASCUAL MEDINAARTURO;FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS MARIA;MARTIN PARA ISMAEL;GARCIA GONZALEZ OSCAR;CASTRILLO IGLESIASJUAN CARLOS. Fe de erratas: Por error se omitió publicar el 14 de agosto de 2014, el nombramiento de los 7 consejeros delegadosmancomunados: JUAN CARLOS CASTRILLO IGLESIAS, LUIS MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ, OSCAR GARCIA GONZALEZ,ISMAEL MARTIN PARA, ANGEL JOSE MARTINEZ GUTIERREZ, ARTURO PASCUAL MEDINA Y JUAN CARLOS PEÑA HERRERO.Datos registrales. T 678, L 469, F 219, S 8, H BU 13792, I/A 9 R ( 8.04.15).
19 de Noviembre de 2014Cambio de domicilio social. AVDA REYES CATOLICOS 43 BAJO 5 (BURGOS). Datos registrales. T 678, L 469, F 218, S 8, H BU13792, I/A 8 (13.11.14).
22 de Agosto de 2014Nombramientos. Presidente: PEÑA HERRERO JUAN CARLOS. Secretario: MARTINEZ GUTIERREZ ANGEL JOSE. Datosregistrales. T 678, L 469, F 218, S 8, H BU 13792, I/A 7 (14.08.14).