Buscador CIF Logo

Actos BORME Lynx Commercial Re Spain Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Lynx Commercial Re Spain Sl

Actos BORME Lynx Commercial Re Spain Sl - B87480760

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Lynx Commercial Re Spain Sl con CIF B87480760

🔙 Perfil de Lynx Commercial Re Spain Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Lynx Commercial Re Spain Sl

18 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: SHELLBROOK INVESTMENT SL. Nombramientos. VsecrNoConsj: ALONSO ALONSO MARIA.Apoderado: SHELLBROOK INVESTMENT SL. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LOPEZ MARTA;GARAYALDE BEGUIRISTAIN SUSANA.Datos registrales. T 46000 , F 215, S 8, H M 620427, I/A 16 (11.12.23).

14 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Consejero: WEBB SEAN. Cons.Del.Sol: WEBB SEAN. Presidente: WEBB SEAN. Datos registrales. T 39084 , F174, S 8, H M 620427, I/A 15 ( 5.12.23).

16 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGESS CHRISTIAN JOHN. Presidente: BURGESS CHRISTIAN JOHN. Cons.Del.Sol: BURGESSCHRISTIAN JOHN. Revocaciones. Apoderado: PATEL AARISH NAVIN. Datos registrales. T 39084 , F 174, S 8, H M 620427, I/A14 ( 8.05.23).

23 de Mayo de 2022
Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 46, 2º A (MADRID). Datos registrales. T 39084 , F 173, S 8, H M 620427, I/A 13(14.05.22).

02 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: INTERTRUST (SPAIN) SL;BURGESS CHRISTIAN JOHN. Representan: DIEZ ARRANZBEATRIZ. Revocaciones. Apoderado: BURGESS CHRISTIAN JOHN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos. Consejero:BURGESS CHRISTIAN JOHN;TORRES SERRANO JUAN DIEGO;GALAYO SANCHEZ ANGEL LUIS. Presidente: BURGESSCHRISTIAN JOHN. Cons.Del.Sol: BURGESS CHRISTIAN JOHN;TORRES SERRANO JUAN DIEGO. Apoderado: PATEL AARISHNAVIN;SANCHEZ LOPEZ MARTA;MCLEAN RYAN;GALAYO SANCHEZ ANGEL LUIS;GRAS VELAZQUEZ AZALEA;BRACALIDAMIANO;CONDE MARIN XABIER;JIMENEZ IGLESIAS IAGO;VAN ZYL AMANDA JANE;ABAD LORENTEMERCEDES;GARAYALDE BEGUIRISTAIN SUSANA. SecreNoConsj: ABAD LORENTE MERCEDES. Otros conceptos: Cambio del

05 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: PICO ESPASA LUCAS;VIÑA DE LA VEGA ALICIA;GREGORIO VILLEGAS LORENA;MADRIGALGONZALEZ IRENE;BARRIOS ZARATE MARIA CONCEPCION;ANDRES GUDINO MARIA GRACIA;ALONSO PEREZ CRISTEL.Datos registrales. T 39084 , F 166, S 8, H M 620427, I/A 9 (27.04.21).

Nombramientos. Apoderado: YEBRA GARCIA SONIA;PICO ESPASA LUCAS;VIÑA DE LA VEGA ALICIA;GREGORIO VILLEGASLORENA;MADRIGAL GONZALEZ IRENE;BARRIOS ZARATE MARIA CONCEPCION;ANDRES GUDINO MARIA GRACIA;ALONSOPEREZ CRISTEL. Datos registrales. T 39084 , F 168, S 8, H M 620427, I/A 10 (27.04.21).

Nombramientos. Apoderado: PICO ESPASA LUCAS;CAMPOS GOMEZ NATALIA;ALDAI CLEMENTE BEATRIZ. Datos registrales.T 39084 , F 169, S 8, H M 620427, I/A 11 (27.04.21).

06 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: SHELLBROOK INVESTMENT SL. Datos registrales. T 39084 , F 163, S 8, H M 620427, I/A 8(26.03.21).

07 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: CALL GREGORY LAWRENCE;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos. Apoderado: BURGESSCHRISTIAN JOHN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 34496 , F 160, S 8, H M 620427, I/A 7 (31.05.19).

20 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CALL GREGORY LAWRENCE. Nombramientos. Adm. Mancom.: BURGESS CHRISTIANJOHN. Datos registrales. T 34496 , F 160, S 8, H M 620427, I/A 6 (13.03.19).

26 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41, 4ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 34496 , F 159, S 8, H M 620427, I/A 5(16.02.18).

09 de Febrero de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ENCORE EUROPE HOLDINGS SARL. Datos registrales. T 34496 ,F 159, S 8, H M 620427, I/A 4 (30.01.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información