Actos BORME de M Actions Data Sl
27 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: RIVERO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42583 , F 1, S 8, H M 289188, I/A 16 (20.04.22).
21 de Octubre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.856,00 Euros. Resultante Suscrito: 135.056,00 Euros. Datos registrales. T 16910 , F 148, S 8, HM 289188, I/A 15 (14.10.21).
12 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HUEDO CORDOBA ANTONIO. Presidente: HUEDO CORDOBA ANTONIO. Nombramientos.Presidente: HUEDO MONGE ANTONIO FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: HUEDO MONGE FRANCISCO JAVIER;HUEDOMONGE ANTONIO;GAGO DEL BUEY MIGUEL ANGEL. Secretario: GAGO DEL BUEY MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: HUEDOMONGE ANTONIO. Datos registrales. T 16910 , F 148, S 8, H M 289188, I/A 14 ( 5.08.21).
20 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: RIVERO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16910 , F 148, S 8, H M 289188, I/A 13 (13.02.19).
18 de Octubre de 2016Ampliacion del objeto social. - El comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas y de todo tipo de art铆culospara fumadores. - La producci贸n y comercializaci贸n de productos electr贸nicos. Producci贸n, comercializaci贸n y distribuci贸n deproductos de recarga para cigarrillos... Datos registrales. T 16910 , F 147, S 8, H M 289188, I/A 12 (10.10.16).
18 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: GARCIA RUBIO JORGE;AIT AHMED ABDELJALIL. Datos registrales. T 16910 , F 147, S 8, H M289188, I/A 11 (10.02.16).
21 de Enero de 2015Cambio de domicilio social. AVDA DE LA VICTORIA 50 (MADRID). Datos registrales. T 16910 , F 146, S 8, H M 289188, I/A 10(14.01.15).
17 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: AIT AHMED ABDELJALIL. Datos registrales. T 16910 , F 146, S 8, H M 289188, I/A 9 ( 5.05.11).
02 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: HUEDO MONGE ANTONIO. Datos registrales. T 16910 , F 145, S 8, H M 289188, I/A 8 (22.11.10).