Buscador CIF Logo

Actos BORME Macur Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Macur Sa

Actos BORME Macur Sa - A28106573

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Macur Sa con CIF A28106573

馃敊 Perfil de Macur Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Macur Sa

30 de Marzo de 2023
Reelecciones. Consejero: SANCHEZ CALVIN JULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL. Presidente: CALVIN GRANADOS MANUEL.Consejero: CALVIN GRANADOS MARIA DOLORES. Secretario: SANCHEZ CALVIN JULIAN. Cons.Del.Sol: SANCHEZ CALVINJULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL;CALVIN GRANADOS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 2966 , F 158, S 8, H M 50866,I/A 18 (23.03.23).

26 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: SANCHEZ CALVIN JULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL;CALVIN GRANADOS MARIADOLORES. Nombramientos. Cons.Del.Sol: SANCHEZ CALVIN JULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL;CALVIN GRANADOSMARIA DOLORES. Reelecciones. Consejero: SANCHEZ CALVIN JULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL. Presidente: CALVINGRANADOS MANUEL. Consejero: CALVIN GRANADOS MARIA DOLORES. Secretario: SANCHEZ CALVIN JULIAN. Datosregistrales. T 2966 , F 158, S 8, H M 50866, I/A 17 (19.03.18).

11 de Julio de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 199.986,78 Euros. Desembolsado: 199.986,78 Euros. Resultante Suscrito: 410.082,58 Euros.Resultante Desembolsado: 410.082,58 Euros. Datos registrales. T 2966 , F 157, S 8, H M 50866, I/A 16 ( 3.07.13).

14 de Marzo de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 149.994,59 Euros. Desembolsado: 149.994,59 Euros. Resultante Suscrito: 210.095,80 Euros.Resultante Desembolsado: 210.095,80 Euros. Datos registrales. T 2966 , F 156, S 8, H M 50866, I/A 15 ( 6.03.13).

30 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DE HOCES ELDUAYEN MERCEDES;DE HOCES ELDUAYEN JOSE RAMON. Nombramientos.Consejero: SANCHEZ CALVIN JULIAN; CALVIN GRANADOS MANUEL. Presidente: CALVIN GRANADOS MANUEL. Consejero:CALVIN GRANADOS MARIA DOLORES. Secretario: SANCHEZ CALVIN JULIAN. Cons.Del.Man: SANCHEZ CALVIN JULIAN;CALVIN GRANADOS MANUEL;CALVIN GRANADOS MARIA DOLORES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.SE MODIFICA LA COMPOSICION DEL ORGANO DEADMINISTRACION, Y COMO CONSECUENCIA SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 6, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Cambio de domicilio social. C/ ALBERTO BOSCH 17 (MADRID). Datos registrales. T 2966 , F 154, S 8, H M 50866,I/A 13 (18.10.12).

Nombramientos. Apoderado: CALVIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2966 , F 155, S 8, H M 50866, I/A 14(18.10.12).

11 de Enero de 2010
Cambio de domicilio social. C/ ZURBANO 49 - OFICINA 17 (MADRID). Datos registrales. T 2966 , F 154, S 8, H M 50866, I/A 12(29.12.09).

03 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Adm. Solid.: DE HOCES ELDUAYEN MERCEDES;DE HOCES ELDUAYEN JOSE RAMON. Datos registrales. T2966 , F 154, S 8, H M 50866, I/A 11 (21.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n