Actos BORME de Madic Iberia Sl
03 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: BLOSSIER CHRISTIAN ANDRE MAURICE. Presidente: BLOSSIER CHRISTIAN ANDRE MAURICE.Nombramientos. Consejero: BLOSSIER SOPHIE ANNE. Presidente: BLOSSIER SOPHIE ANNE. Datos registrales. T 663, L 454, F208, S 8, H BU 3488, I/A 24 (27.10.23).
10 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: AUD&CON QUALITY SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 208, S 8, H BU 3488, I/A 23 ( 4.10.22).
24 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA SAIOA. Datos registrales. T 663, L 454, F 207, S 8, H BU 3488, I/A 22 (18.09.20).
13 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: GOMEZ HERNANDO ANGEL. Datos registrales. T 663, L 454, F 207, S 8, H BU 3488, I/A 21 (3.04.20).
27 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: AUD&CON QUALITY SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 206, S 8, H BU 3488, I/A 20 (21.03.19).
14 de Septiembre de 2016Reelecciones. Auditor: AUD&CON QUALITY SL. Datos registrales. T 663, L 454, F 206, S 8, H BU 3488, I/A 19 ( 8.09.16).
31 de Diciembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GUTIERREZ GARAY JUAN ANTONIO. Aud.Supl.: DE LA FUENTEGONZALEZ DE LAS CUEVAS EDUARDO. Nombramientos. Auditor: AUD&CON QUALITY SL. Datos registrales. T 663, L 454, F206, S 8, H BU 3488, I/A 18 (24.12.13).
02 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: VILLAIZAN GUEZMES IGNACIO. Datos registrales. T 480, L 271, F 70, S 8, H BU 3488, I/A 17(25.06.13).
26 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: DE MATEO GARCIA GUILLERMO. Datos registrales. T 480, L 271, F 69, S 8, H BU 3488, I/A 16(20.06.13).