Actos BORME de Madrid 404 Sociedad Concesionaria Sa
22 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO SAYAS MARIA LUISA;GARCIA GARCIA ALBERTO;GARCIA PEREIRA LAURA. Presidente:CASTRO SAYAS MARIA LUISA. Secretario: GARCIA PEREIRA LAURA. VsecrNoConsj: GALDIZ DE LA PLAZA ITZIAR.Nombramientos. Liquidador: RAMOS PEREZ FAUSTINO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 34480 , F 123,S 8, H M 454191, I/A 28 (15.02.19).
23 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34480 , F 123, S 8, H M 454191, I/A 27 (11.10.18).
11 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34480 , F 123, S 8, H M 454191, I/A 26 (29.11.17).
28 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 34480 , F 122, S 8, H M 454191, I/A 25 (16.12.16).
14 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA PEREIRA LAURA. Representan: CASTRO SAYAS MARIA LUISA;CASTRO SAYASMARIA LUISA;GARCIA PEREIRA LAURA. Consejero: ORFEO INFRAESTRUCTURAS SL. Presidente: ORFEOINFRAESTRUCTURAS SL. Consejero: LIBUSA INFRAESTRUCTURAS SL;DALIBOR INFRAESTRUCTURAS SL. Nombramientos.Consejero: CASTRO SAYAS MARIA LUISA;GARCIA GARCIA ALBERTO;GARCIA PEREIRA LAURA. Presidente: CASTRO SAYASMARIA LUISA. Secretario: GARCIA PEREIRA LAURA. Datos registrales. T 34480 , F 122, S 8, H M 454191, I/A 24 ( 4.11.16).
12 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: RAMOS PEREZ FAUSTINO;CASTRO SAYAS MARIA LUISA;SANCHEZ SALMERON LUIS;GARCIARECIO JOSE LUIS;ALONSO OTERO ESTHER. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA ALBERTO;CASTRO SAYASMARIA LUISA;RAMOS PEREZ FAUSTINO;CASTRO GIMENEZ BELEN;ALONSO OTERO ESTHER. Datos registrales. T 25220 , F213, S 8, H M 454191, I/A 23 ( 5.04.16).
28 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA280 (MADRID). Datos registrales. T 25220 , F 213, S 8, H M 454191, I/A 22 (18.12.15).
10 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25220 , F 213, S 8, H M 454191, I/A 21 ( 1.12.15).
10 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25220 , F 212, S 8, H M 454191, I/A 20 ( 2.02.15).
22 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: SANCHEZ SALMERON LUIS. Nombramientos. Representan: CASTRO SAYAS MARIA LUISA.Datos registrales. T 25220 , F 212, S 8, H M 454191, I/A 19 (15.12.14).
10 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25220 , F 212, S 8, H M 454191, I/A 18 (29.08.14).
17 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: AMFORTAS INFRAESTRUCTURAS SL;ORFEO INFRAESTRUCTURAS SL;LIBUSAINFRAESTRUCTURAS SL;DALIBOR INFRAESTRUCTURAS SL. Presidente: ORFEO INFRAESTRUCTURAS SL. Representan:PEREZ GIL ANTONIO;CASTRO SAYAS MARIA LUISA;MEDINA VAZQUEZ BELEN;LOPEZ SALAZAR AMPARO. Nombramientos.Representan: SANCHEZ SALMERON LUIS;CASTRO SAYAS MARIA LUISA;GARCIA PEREIRA LAURA. Consejero: ORFEOINFRAESTRUCTURAS SL. Presidente: ORFEO INFRAESTRUCTURAS SL. Consejero: LIBUSA INFRAESTRUCTURAS SL;DALIBORINFRAESTRUCTURAS SL. Datos registrales. T 25220 , F 211, S 8, H M 454191, I/A 17 ( 9.07.14).
06 de Junio de 2014Otros conceptos: SE MODIFICA EL CALENDARIO DEL DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS, MODIFICANDOSEASIMISMO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 25220 , F 211, S 8, H M 454191, I/A 16(30.05.14).
05 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25220 , F 211, S 8, H M 454191, I/A 15 (28.01.13).
13 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE JOSE FELIPE. VsecrNoConsj: GARCIA PEREIRALAURA. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA PEREIRA LAURA. VsecrNoConsj: GALDIZ DE LA PLAZA ITZIAR. Datosregistrales. T 25220 , F 210, S 8, H M 454191, I/A 14 ( 3.07.12).
30 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25220 , F 210, S 8, H M 454191, I/A 13 (20.03.12).
27 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25220 , F 210, S 8, H M 454191, I/A 12 (13.03.12).
02 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: RAMOS PEREZ FAUSTINO;GARCIA FERNANDEZ MARIA LUISA;FALCES VALLE FRANCISCOJAVIER;MATALLANA GONZALEZ LUIS GREGORIO;CORRAL FERNANDEZ FELIX;PEREZ GIL ANTONIO;FALCES VALLEFRANCISCO JAVIER;MATALLANA GONZALEZ LUIS GREGORIO;CORRAL FERNANDEZ FELIX;PEREZ GIL ANTONIO.Nombramientos. Apoderado: RAMOS PEREZ FAUSTINO;CASTRO SAYAS MARIA LUISA;SANCHEZ SALMERON LUIS;GARCIARECIO JOSE LUIS;ALONSO OTERO ESTHER. Datos registrales. T 25220 , F 208, S 8, H M 454191, I/A 11 (20.02.12).
07 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA CRESPO PEDRO. Nombramientos. Representan: LOPEZ SALAZAR AMPARO. Datosregistrales. T 25220 , F 208, S 8, H M 454191, I/A 10 (23.08.11).
30 de Noviembre de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo 5º. Capital Social. Datos registrales. T 25220 , F 207, S 8, H M 454191, I/A 9 (19.11.10).
09 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: CORRAL FERNANDEZ FELIX;MATALLANA GONZALEZ LUIS GREGORIO;FALCES VALLESFRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: CASTRO SAYAS MARIA LUISA;MEDINA VAZQUEZ BELEN;GARCIACRESPO PEDRO. Datos registrales. T 25220 , F 207, S 8, H M 454191, I/A 8 (27.11.09).
08 de Junio de 2009Modificaciones estatutarias. Ha sido modificado el Artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la modificación delcalendario previsto para el desembolso de dividendos pasivos.-. Datos registrales. T 25220 , F 206, S 8, H M 454191, I/A 7(27.05.09).