Buscador CIF Logo

Actos BORME Madrid Redes De Campo Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Madrid Redes De Campo Sa

Actos BORME Madrid Redes De Campo Sa - A59835132

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Madrid Redes De Campo Sa con CIF A59835132

🔙 Perfil de Madrid Redes De Campo Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Madrid Redes De Campo Sa

27 de Abril de 2021
Otros conceptos: CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA EL 8 DE MARZO DE 2021REFERENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 R.R.M. Extinción. Datos registrales. T 30563 , F 188, S 8, H M 550072,I/A 11 (20.04.21).

30 de Noviembre de 2020
Declaración de unipersonalidad. Socio único: GREY IBERIA SL. Datos registrales. T 30563 , F 188, S 8, H M 550072, I/A 10(23.11.20).

26 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HIMPE STEFAN LEO H. Presidente: HIMPE STEFAN LEO H. Nombramientos. Consejero: ADAMSCLAUS. Presidente: GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA. Datos registrales. T 30563 , F 187, S 8, H M 550072, I/A 9 (19.11.20).

03 de Diciembre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ RIOS ROSAS 26 (MADRID). Datos registrales. T 30563 , F 187, S 8, H M 550072, I/A 8 (26.11.19).

05 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DADRA RAJ KUMAR;LEONE PIETRO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ POVEDA MARIAJOSE. Nombramientos. Consejero: SADIQ SHAHID;GEOMETRY GLOBAL SPAIN SA. Representan: RIVA LARIOS LUIS. Cambiode domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 39 (MADRID). Datos registrales. T 30563 , F 186, S 8, H M 550072, I/A 7 (29.05.18).

30 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: RIVA LARIOS LUIS JORGE. Datos registrales. T 30563 , F 184, S 8, H M 550072, I/A 6 (23.09.16).

24 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apoderado: VILA MANCHO ENRIQUE;CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS;CANTERA URCIA JUANMANUEL. Nombramientos. Consejero: HIMPE STEFAN LEO H. Presidente: HIMPE STEFAN LEO H. SecreNoConsj: MARTINEZIGLESIAS FRANCISCO. VsecrNoConsj: OLABARRI GORTAZAR PABLO. Apo.Man.Soli: COLMENAREJO ALONSO LUISMIGUEL;PEREZ POVEDA MARIA JOSE. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y webcorporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 37 BIS - 6º PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 30563 , F182, S 8, H M 550072, I/A 5 (12.08.16).

17 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS;CANTERA URCIA JUAN MANUEL. Presidente:CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS. Con.Delegado: CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS. Secretario: CANTERAURCIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 30563 , F 182, S 8, H M 550072, I/A 4 ( 9.12.14).

22 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GARCIA GALLARDO BELEN;CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS;CANTERAURCIA JUAN MANUEL;ECHALECU MARIN CARLOS. Datos registrales. T 30563 , F 180, S 8, H M 550072, I/A 3 (13.03.13).

21 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. GRAN VIA 1, 2º (MADRID).Datos registrales. T 30563 , F 180, S 8, H M 550072, I/A 2 (12.03.13).

18 de Febrero de 2013
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: RIAÑO GARCIA JAVIER;JOHN EDWARD ARNOTT LYNN. Nombramientos. CONSEJERO:RAJ KUMAR DADRA;CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS. PRESIDENTE: CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS.CONS. DELEG.: CABRERA YAGUES FRANCISCO CARLOS. CONSEJERO: CANTERA URCIA JUAN MANUEL. SECRETARIO:CANTERA URCIA JUAN MANUEL. CONSEJERO: PIETRO LEONE. Modificaciones estatutarias. ARTS.8 Y 10:CAMBIO DEREGIMEN ADMINISTRATIVO Y MODIFICACIONDEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 41472 , F 144, S 8, H B 18487, I/A 31 ( 4.02.13).

15 de Noviembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: NARCISO MOTA BUIL JESUS FERNANDO. Datos registrales. T 41472 , F 144, S 8, H B 18487, I/A30 ( 3.11.11).

09 de Agosto de 2010
Revocaciones. APODERADO: AMAT SALA JAVIER;MOTA BUIL JESUS FERNANDO NARCISO. Nombramientos. APODERADO:RIVERO PEREZ ALBERTO;AMAT SALA JAVIER;NARCISO MOTA BUIL JESUS FERNANDO. Datos registrales. T 41472 , F 141, S8, H B 18487, I/A 29 (29.07.10).

27 de Octubre de 2009
Nombramientos. APODERADO: MORENO INOCENCIO MANUEL. Datos registrales. T 34955 , F 183, S 8, H B 18487, I/A 28(15.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información