Buscador CIF Logo

Actos BORME Madrid Xanadu 2003 Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Madrid Xanadu 2003 Sl

Actos BORME Madrid Xanadu 2003 Sl - B83141085

Tenemos registrados 60 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Madrid Xanadu 2003 Sl con CIF B83141085

🔙 Perfil de Madrid Xanadu 2003 Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Madrid Xanadu 2003 Sl

07 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36476 , F 108, S 8, H M 291455, I/A 87 (28.02.23).

15 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ NAVARRO JORGE. Secretario: GONZALEZ NAVARRO JORGE. Presidente: CLADERADE CODINA MARTA. Vicepresid.: MEULENDIJK MAURICE. Nombramientos. Consejero: BRUZON BARRERAS ALVARO.Secretario: BRUZON BARRERAS ALVARO. Presidente: MEULENDIJK MAURICE. Vicepresid.: CLADERA DE CODINA MARTA.Datos registrales. T 36476 , F 107, S 8, H M 291455, I/A 86 ( 8.06.21).

29 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: RIVES RUIZ-TAPIADOR CARLOS;SALCES RANERO SUSANA;CARAZO GARCIA JOSELUIS;FUENTES FERNANDEZ JORGE;LOPEZ CERON HOYOS SOLEDAD;RIVES RUIZ-TAPIADOR CARLOS;CALVO GARCIAFERNANDO;GONZALEZ SARDINO DANIELA;MARTIN DE LA PEÑA ALEXIS. Datos registrales. T 36476 , F 103, S 8, H M 291455,I/A 85 (22.03.21).

19 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GROSS GASSET ALVARO. Apo.Manc.: GROSS GASSET ALVARO. Apo.Sol.: GROSS GASSET ALVARO.Apo.Manc.: GROSS GASSET ALVARO. Apo.Sol.: GROSS GASSET ALVARO. Apo.Manc.: BREEDEN MARTIN RICHARD;PILAOMOREIRA RUI MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;PELAEZ VARA JULIA;LOPEZ BARRANCO ROCIO;MAYA DONAIRERAQUEL;BREEDEN MARTIN RICHARD;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;GUILLAMONCRIADO PABLO;LOPEZ BARRANCO ROCIO;PELAEZ VARA JULIA;MAYA DONAIRE RAQUEL. Apo.Sol.: BREEDEN MARTINRICHARD;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;LOPEZ BARRANCO ROCIO. Apo.Manc.:FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAOMOREIRA RUI MANUEL. Nombramientos. Apoderado: BRUZON BARRERAS ALVARO;CBRE REAL ESTATE SA. Datosregistrales. T 36476 , F 100, S 8, H M 291455, I/A 84 (12.02.21).

28 de Enero de 2021
Cambio de domicilio social. C/ PUERTO DE NAVACERRADA S/N - OFICINAS DE GERENCI (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 36476 , F 99, S 8, H M 291455, I/A 83 (21.01.21).

10 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLAMON CRIADO PABLO. Vicesecret.: GUILLAMON CRIADO PABLO. Nombramientos.Consejero: URRUTIA DEL POZO JOSE. Vicesecret.: URRUTIA DEL POZO JOSE. Datos registrales. T 36476 , F 99, S 8, H M291455, I/A 82 (30.10.20).

31 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBANY FERNANDEZ ALEX. Vicesecret.: BARBANY FERNANDEZ ALEX. Revocaciones.Apo.Manc.: BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO. Apo.Sol.: BARBANY FERNANDEZALEJANDRO. Apo.Manc.: BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO. Nombramientos.Consejero: GUILLAMON CRIADO PABLO. Vicesecret.: GUILLAMON CRIADO PABLO. Datos registrales. T 36476 , F 98, S 8, H M291455, I/A 81 (25.01.20).

18 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36476 , F 98, S 8, H M 291455, I/A 80 (11.11.19).

15 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO SUAREZ ADOLFO;CABELLO MARTINEZ GABRIEL;BLANCO SANFRUTOSRAQUEL;GALINDO GARCIA ANA;BERNALDEZ IGLESIAS ROSARIO;ALFONSETTI LOPEZ SANTIAGO;BLANCO DIAZSILVIA;CASTAÑO DAVIS LUIS DANIEL;ISIDRO READ INES DEL CARMEN;DE ELEJABEITIA AGUDO VICTOR. Datos registrales.T 36476 , F 98, S 8, H M 291455, I/A 79 ( 8.11.19).

17 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;ALONSOPASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL. Apo.Manc.: BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL. Apo.Man.Soli:BREEDEN MARTIN RICHARD;BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA POZO JOSE;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;SANCHEZJIMENEZ MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;LOPEZ BARRANCO ROCIO;MAYA DONAIRE RAQUEL. Apo.Manc.: BREEDENMARTIN RICHARD;URRUTIA POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;BARBANY FERNANDEZ ALEX;ALONSO PASCUALJOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;SANCHEZ JIMENEZ MANUEL;MAYA DONAIRERAQUEL;LOPEZ BARRANCO ROCIO. Apo.Sol.: BREEDEN MARTIN RICHARD;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARROJORGE;BARBANY FERNANDEZ ALEX;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;LOPEZ BARRANCOROCIO. Nombramientos. Apo.Manc.: BREEDEN MARTIN RICHARD;BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;GONZALEZNAVARRO JORGE;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;URRUTIA DEL POZO JOSE;PELAEZ VARAJULIA;LOPEZ BARRANCO ROCIO;MAYA DONAIRE RAQUEL;GONZALEZ NAVARRO JORGE;BARBANY FERNANDEZALEJANDRO;BREEDEN MARTIN RICHARD;URRUTIA DEL POZO JOSE;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAOMOREIRA RUI MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;LOPEZ BARRANCO ROCIO;PELAEZ VARA JULIA;MAYA DONAIRERAQUEL. Apo.Sol.: BREEDEN MARTIN RICHARD;BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;GONZALEZ NAVARRO JORGE;URRUTIADEL POZO JOSE;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;LOPEZ BARRANCO ROCIO.Apo.Manc.: BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;GONZALEZ NAVARRO JORGE;URRUTIA DEL POZO JOSE;FERNANDES DEQUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;BARBANY FERNANDEZ ALEJANDRO;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;FERNANDES DE QUINA CARLOS ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL. Datosregistrales. T 36476 , F 93, S 8, H M 291455, I/A 78 (10.09.19).

21 de Junio de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: XANADU RETAIL AND LEISURE SL. Datos registrales. T 36476 ,F 93, S 8, H M 291455, I/A 77 (14.06.19).

21 de Marzo de 2019
Otros conceptos: subsanación de la inscripcion 74ª de esta hoja, en cuanto al objeto social.- Ampliacion del objeto social. b)activos que sean necesarios para la gestión de propiedades inmobiliarias; y/o (c) (1) depósitos bancarios; (2) instrumentos monetarios;(3) valores que sean admitidos como garantía por el Banco Central Europeo o el Banco Central Alemán (Deutsche Bundesbank) paralas operaciones de crédito del art. Datos registrales. T 36476 , F 92, S 8, H M 291455, I/A 76 (13.03.19).

07 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE LA PEÑA ALEXIS. Datos registrales. T 36476 , F 91, S 8, H M 291455, I/A 75 (28.02.19).

06 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Apo.Manc.: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Apo.Man.Soli: DE PABLOLOPEZ MERCEDES. Apo.Manc.: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Apo.Sol.: DE PABLO LOPEZ MERCEDES. Datos registrales. T36476 , F 90, S 8, H M 291455, I/A 73 (30.01.19).

Modificaciones estatutarias. 7.bis. supresión del artículo 7. bis. Cambio de objeto social. La sociedad tiene porobjeto comprar,poseer y gestionar por su cuenta propiedades ya promovidas propiedades designadas para ser promovidas en España (las"Propiedades") y gestionar el funcionamiento de los establecimientos e instalaciones de comercio minorista ubicadas entesPropiedades. A los efect. Datos registrales. T 36476 , F 90, S 8, H M 291455, I/A 74 (30.01.19).

04 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36476 , F 90, S 8, H M 291455, I/A 72 (27.11.18).

18 de Septiembre de 2018
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 64 (MADRID). Datos registrales. T 36476 , F 89, S 8, H M 291455, I/A70 (10.09.18).

Modificaciones estatutarias. Se incorpora un nuevo artículo a los Estatutos sociales, el 7 bis.. Cambio de objeto social. la. Datosregistrales. T 36476 , F 89, S 8, H M 291455, I/A 71 (10.09.18).

19 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: TMF MANAGEMENT SPAIN SL. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ HERMIDA FRANCISCO. Datos registrales. T36476 , F 89, S 8, H M 291455, I/A 69 (11.06.18).

15 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 36476 , F 88, S 8, H M 291455, I/A 68 ( 4.01.18).

09 de Enero de 2018
Modificaciones estatutarias. HA QUEDADO MODIFICADO EL OBJETO SOCIALES Y EL ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES Y HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 11º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SOBRE "USUFRUCTO Y PRENDADE LAS PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD.-. Cambio de objeto social. COMPRAR, POSEER Y GESTIONAR POR SUCUENTA PROPIEDADES YA PROMOVIDAS O PROPIEDADES DESIGNADAS PARA SER PROMOVIDAS EN ESPAÑA YGESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE COMERCIO MINORISTA UBICADOSEN LAS PROPIEDADES.- Datos registrales. T 36476 , F 88, S 8, H M 291455, I/A 67 ( 2.01.18).

08 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;TMF MANAGEMENTSPAIN SL;BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARROJORGE;VAZQUEZ HERMIDA FRANCISCO;GUILLAMON CRIADO PABLO;CBRE GESTION INMOBILIARIA SL;HODSON NICHOLASJOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUALJOSE ALBERTO;BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZNAVARRO JORGE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO. Apo.Manc.: VINER HODSON NICKJOHN;URRUTIA DEL POZO JOSE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO. Datos registrales. T36476 , F 84, S 8, H M 291455, I/A 63 (31.10.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: BREEDEN MARTIN RICHARD;BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA POZO JOSE;DE PABLOLOPEZ MERCEDES;GONZALEZ NAVARRO JORGE;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;VAZQUEZ HERMIDA FRANCISCO;SANCHEZJIMENEZ MANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;LOPEZ BARRANCO ROCIO;MAYA DONAIRE RAQUEL. Datos registrales. T36476 , F 85, S 8, H M 291455, I/A 64 (31.10.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: BREEDEN MARTIN RICHARD;URRUTIA POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLOLOPEZ MERCEDES;BARBANY FERNANDEZ ALEX;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUIMANUEL;GUILLAMON CRIADO PABLO;SANCHEZ JIMENEZ MANUEL;MAYA DONAIRE RAQUEL;LOPEZ BARRANCOROCIO;GROSS GASSET ALVARO. Datos registrales. T 36476 , F 86, S 8, H M 291455, I/A 65 (31.10.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: BREEDEN MARTIN RICHARD;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLOLOPEZ MERCEDES;BARBANY FERNANDEZ ALEX;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;LOPEZBARRANCO ROCIO;GROSS GASSET ALVARO. Datos registrales. T 36476 , F 87, S 8, H M 291455, I/A 66 (31.10.17).

07 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CBRE GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 17034 , F 224, S 8, H M 291455, I/A 62(30.10.17).

06 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: TMF MANAGEMENT SPAIN SL. Representan: GARRIGUES CALDERON BELEN. Consejero:BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE. Presidente: BREEDEN MARTINRICHARD. Vicepresid.: HODSON NICHOLAS JOHN VINER. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ NAVARROJORGE;BARBANY FERNANDEZ ALEX;MEULENDIJK MAURICE;CLADERA DE CODINA MARTA. Presidente: CLADERA DECODINA MARTA. Vicepresid.: MEULENDIJK MAURICE. Secretario: GONZALEZ NAVARRO JORGE. Vicesecret.: BARBANY

Nombramientos. Apoderado: INTU MANAGEMENT SPAIN SL. Datos registrales. T 17034 , F 221, S 8, H M 291455, I/A 58(27.10.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLOLOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;GROSS GASSET ALVARO. Datosregistrales. T 17034 , F 223, S 8, H M 291455, I/A 59 (27.10.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: BARBANY FERNANDEZ ALEX;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DEPABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO;PILAO MOREIRA RUI MANUEL;GROSS GASSET ALVARO.Datos registrales. T 17034 , F 223, S 8, H M 291455, I/A 60 (27.10.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: TMF MANAGEMENT SPAIN SL;GROSS GASSET ALVARO. Datos registrales. T 17034 , F 224, S 8, HM 291455, I/A 61 (27.10.17).

09 de Junio de 2017
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: INTU XANADU BIDCO SPAIN SL. Datos registrales. T 17034 , F 213, S 8, H M291455, I/A 56 (29.05.17).

30 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: VINER HODSON NICK JOHN;URRUTIA DEL POZO JOSE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSOPASCUAL JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 17034 , F 212, S 8, H M 291455, I/A 54 (22.05.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: GULLON CABRERO ALBERTO;LALONDE PIERRE;DAVID PAUL;FILION VINCENT;LAPORTECHANTAL.Apo.Man.Soli: GULLON CABRERO ALBERTO;DAVID PAUL;FILION VINCENT;LAPORTE CHANTAL. Apoderado:MORENO CELDA ANGEL. Apo.Man.Soli: MAYA DONAIRE RAQUEL. Apoderado: LOPEZ BARRANCO ROCIO. Datos registrales. T17034 , F 213, S 8, H M 291455, I/A 55 (22.05.17).

26 de Mayo de 2017
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 212, S 8, H M 291455, I/A 53 (19.05.17).

22 de Mayo de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: INTU XANADU BIDCO SPAIN SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:GULLON CABRERO ALBERTO. Presidente: GULLON CABRERO ALBERTO. Con.Delegado: GULLON CABRERO ALBERTO.Consejero: IBAÑEZ DIEZ MIGUEL;VIARD JEAN CHARLES. Secretario: IBAÑEZ DIEZ MIGUEL. Nombramientos. SecreNoConsj:TMF MANAGEMENT SPAIN SL. Representan: GARRIGUES CALDERON BELEN. Consejero: BREEDEN MARTINRICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE. Presidente: BREEDEN MARTIN RICHARD. Vicepresid.:HODSON NICHOLAS JOHN VINER. Modificaciones estatutarias. Se añade el artículo 19 bis a los estatutos sociales. Cambio dedomicilio social. C/ EDUARDO DATO 18 - PLANTA SEMISOTANO (MADRID). Datos registrales. T 17034 , F 207, S 8, H M291455, I/A 46 (11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO. Datos registrales. T17034 , F 208, S 8, H M 291455, I/A 47 (11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: TMF MANAGEMENT SPAIN SL. Datos registrales. T 17034 , F 209, S 8, H M 291455, I/A 48(11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;VAZQUEZ HERMIDA FRANCISCO;GUILLAMON CRIADO PABLO. Datos registrales. T17034 , F 209, S 8, H M 291455, I/A 49 (11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: CBRE GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 17034 , F 210, S 8, H M 291455, I/A 50(11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZO JOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DEPABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 17034 , F 211, S 8, H M 291455, I/A 51(11.05.17).

Nombramientos. Apoderado: BREEDEN MARTIN RICHARD;HODSON NICHOLAS JOHN VINER;URRUTIA DEL POZOJOSE;GONZALEZ NAVARRO JORGE;DE PABLO LOPEZ MERCEDES;ALONSO PASCUAL JOSE ALBERTO. Datos registrales. T17034 , F 211, S 8, H M 291455, I/A 52 (11.05.17).

16 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LALONDE PIERRE. Nombramientos. Consejero: VIARD JEAN CHARLES. Datos registrales. T17034 , F 206, S 8, H M 291455, I/A 45 ( 4.05.17).

04 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ BARRANCO ROCIO. Datos registrales. T 17034 , F 206, S 8, H M 291455, I/A 44 (27.12.16).

23 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALOMO TARDON ENRIQUE. Datos registrales. T 17034 , F 205, S 8, H M 291455, I/A 42(15.10.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MAYA DONAIRE RAQUEL. Datos registrales. T 17034 , F 205, S 8, H M 291455, I/A 43 (15.10.15).

31 de Agosto de 2015
Modificaciones estatutarias. Refundición de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 17034 , F 203, S 8, H M 291455, I/A 41(24.08.15).

05 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 203, S 8, H M 291455, I/A 40 (29.07.15).

02 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: CHEHAB PAUL SAMIR;LEVASSEUR GERVAIS. Apo.Man.Soli: LEVASSEUR GERVAIS. Datosregistrales. T 17034 , F 202, S 8, H M 291455, I/A 39 (23.01.15).

20 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 202, S 8, H M 291455, I/A 38 (12.08.14).

11 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DION CLAUDE. Nombramientos. Consejero: IBAÑEZ DIEZ MIGUEL. Datos registrales. T 17034 ,F 202, S 8, H M 291455, I/A 37 ( 4.06.14).

23 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 202, S 8, H M 291455, I/A 36 (14.08.13).

22 de Octubre de 2012
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 201, S 8, H M 291455, I/A 35 ( 9.10.12).

31 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: HUEY III CECIL HARDY. Apo.Sol.: HARDY HUEY III CECIL. Apo.Man.Soli: HARDY HUEY III CECIL.Datos registrales. T 17034 , F 201, S 8, H M 291455, I/A 34 (19.05.11).

26 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: ECHARRI ARDANAZ ALBERTO;VAZQUEZ PARDO CONSTANTINO CESAR. Otros conceptos: SEMODIFICA LA FORMA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL APARTADO 'a' DE LAS QUE CONSTAN EN LA ESCRITURAQUE CAUSO LA INSCRIPCION 19& EN CUANTO A LOS SIGUENTES APODERADOS: PAUL DAVID,VINCENT FILION,ALBERTOGULLON CABRERO,CECIL HARDY HUEY III,CHANTAL LAPORTE,GERVAIS LEVASSEUR Y ENRIQUE PALOMO TARDON. Datosregistrales. T 17034 , F 201, S 8, H M 291455, I/A 33 (16.11.10).

12 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: DION CLAUDE. Presidente: DION CLAUDE. Nombramientos. Consejero: GULLON CABREROALBERTO. Presidente: GULLON CABRERO ALBERTO. Con.Delegado: GULLON CABRERO ALBERTO. Datos registrales. T 17034, F 200, S 8, H M 291455, I/A 31 ( 1.03.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CHEHAB PAUL SAMIR. Datos registrales. T 17034 , F 201, S 8, H M 291455, I/A 32 ( 3.03.10).

31 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: TREMBLAY RENE. Presidente: TREMBLAY RENE. Secretario: DION CLAUDE. Nombramientos.SecreNoConsj: IBAÑEZ DIEZ MIGUEL. Presidente: DION CLAUDE. Datos registrales. T 17034 , F 199, S 8, H M 291455, I/A 30(19.12.09).

18 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: MULROY KIERAN;COMERY JOHN WILLIAM;DESLAURIERS MICHEL. Apo.Man.Soli: DESLAURIERSMICHEL;COMERY JOHN WILLIAM. Nombramientos. Apoderado: MORENO CELDA ANGEL. Datos registrales. T 17034 , F 199, S8, H M 291455, I/A 29 ( 3.12.09).

30 de Octubre de 2009
Nombramientos. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 17034 , F 199, S 8, H M 291455, I/A 28(20.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información