Actos BORME de Madrimor Sl
03 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA. Secretario: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA.Cons.Del.Man: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA;MADRIDANO SANZ MARIA JESUS;HERNANDEZ MADRIDANO PABLONombramientos. Consejero: MIZAR INMUEBLES SL. Representan: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA. Cons.Del.Man: MIZARINMUEBLES SL. Secretario: MIZAR INMUEBLES SL. Cons.Del.Man: MADRIDANO SANZ MARIA JESUS;HERNANDEZ MADRIDANOPABLO. Datos registrales. T 14239 , F 17, S 8, H M 234538, I/A 8 (23.03.18).
22 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MADRIDANO MORALES FERNANDO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 6 lapublicaci贸n del cese como consjero y consejero delegado de don Fernando Madridano Morales. Datos registrales. T 14239 , F 16, S8, H M 234538, I/A 6 ( 7.08.15).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MADRIDANO SANZ MARIA JESUS;MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA;HERNANDEZMADRIDANO PABLO Nombramientos. Cons.Del.Man: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA;MADRIDANO SANZ MARIAJESUS;HERNANDEZ MADRIDANO PABLO Datos registrales. T 14239 , F 17, S 8, H M 234538, I/A 7 (15.02.16).
18 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: MADRIDANO SANZ MARIA JESUS. Presidente: MADRIDANO MORALES FERNANDO.Nombramientos. Secretario: MADRIDANO ALBA MARIA GLORIA. Presidente: MADRIDANO SANZ MARIA JESUS. Datosregistrales. T 14239 , F 16, S 8, H M 234538, I/A 6 ( 7.08.15).
19 de Mayo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 384,31 Euros. Resultante Suscrito: 19.081.750,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 8.299.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.782.300,00 Euros. Datos registrales. T 14239 , F 16, S 8, H M 234538, I/A 5 (8.05.15).
14 de Mayo de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ MIRALLOS 12 1潞 D(MADRID). Datos registrales. T 14239 , F 15, S 8, H M 234538, I/A 4 ( 6.05.15).