Actos BORME de Madripaq Servicios Sl
11 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: CHINCHILLA TROYANO ADRIAN. Apo.Manc.: CHINCHILLA TROYANO ADRIAN. Datos registrales.T 34703 , F 82, S 8, H M 197785, I/A 31 ( 4.10.23).
07 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 34703 , F 82, S 8, H M 197785, I/A 30(28.10.22).
24 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO;MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 34703 , F 81, S8, H M 197785, I/A 29 (17.06.22).
08 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Nombramientos. Presidente: DELMAS YVES PIERRE LOUIS.Datos registrales. T 34703 , F 81, S 8, H M 197785, I/A 28 ( 1.03.22).
02 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN;REAL CAMACHO NOELIA;VILLEGAS SANCHEZ MARTAELENA;SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ JUAN LUIS;CHINCHILLA TROYANO ADRIAN. Datos registrales. T 34703 , F 81, S 8, HM 197785, I/A 27 (23.02.22).
24 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARTINEZ MARTIN;REAL CAMACHO NOELIA;NIETO PALMEIROCONSOLACION;VILLEGAS SANCHEZ MARTA ELENA;SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ JUAN LUIS;CHINCHILLA TROYANOADRIAN. Datos registrales. T 34703 , F 79, S 8, H M 197785, I/A 23 (17.02.22).
Nombramientos. Apoderado: VILLEGAS SANCHEZ MARTA ELENA. Datos registrales. T 34703 , F 80, S 8, H M 197785, I/A 24(17.02.22).
Nombramientos. Apoderado: REAL CAMACHO NOELIA. Datos registrales. T 34703 , F 80, S 8, H M 197785, I/A 25 (17.02.22).
Nombramientos. Apoderado: NIETO PALMEIRO CONSOLACION. Datos registrales. T 34703 , F 80, S 8, H M 197785, I/A 26(17.02.22).
20 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER;FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO. SecreNoConsj: PAREJOBALLESTEROS DANIEL. VsecrNoConsj: URBANO JIMENEZ JAVIER;GONZALEZ ORTEGA JUAN MARIA. Nombramientos.SecreNoConsj: LUJAN ESPI ALBERTO. VsecrNoConsj: GARCIA STUYCK MIGUEL LIVINIO. Modificaciones estatutarias.Modificados los art铆culos 10潞, 17潞 y 20潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 34703 , F 78, S 8, H M 197785, I/A 22(13.12.21).
26 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER;CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Nombramientos.Consejero: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA;FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO;VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER;DELMASYVES PIERRE LOUIS;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Presidente: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. SecreNoConsj: PAREJOBALLESTEROS DANIEL. VsecrNoConsj: URBANO JIMENEZ JAVIER;GONZALEZ ORTEGA JUAN MARIA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 34703 , F 76, S8, H M 197785, I/A 19 (18.12.19).
Modificaciones estatutarias. 10. Organos Sociales. 12. Convocatoria. 13. Mayor铆a. 14. Presidente y Secretario. Acta. 16. Asistenciay representaci贸n. 17. Organo de Administraci贸n. 20. Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 34703 , F 77, S 8, H M 197785,I/A 20 (18.12.19).
Nombramientos. Con.Delegado: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Datos registrales. T 34703 , F 78, S 8, H M 197785, I/A 21(18.12.19).
01 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Apoderado: VILLANUEVARODRIGUEZ URBANO JOSE. Apo.Sol.: ORTEGA MARTINEZ ANDRES;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER. Datos registrales. T34703 , F 76, S 8, H M 197785, I/A 18 (24.09.18).
07 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: CUESTA SANCHEZ HIPOLITO NICOLAS;FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO. Datos registrales. T34703 , F 76, S 8, H M 197785, I/A 17 (27.02.17).
13 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VILLANUEVA RUIZ JULIO ALEXANDER. Nombramientos. Adm. Solid.: VILLANUEVA RUIZ JULIOALEXANDER;CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 63.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 126.000,00Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 12431 , F 146, S 8, H M 197785, I/A 14 (5.07.16).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 34703 , F 75, S 8, H M 197785, I/A 15 ( 5.07.16).
Nombramientos. Apoderado: FUEYO RODRIGUEZ ANTONIO;MARTINEZ MARTINEZ MARTIN. Datos registrales. T 34703 , F 75,S 8, H M 197785, I/A 16 ( 5.07.16).
24 de Febrero de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ALUGAR PAZOS SL. Datos registrales. T 12431 , F 146, S 8, H M197785, I/A 13 (15.02.16).
09 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MARTINEZ ANDRES;GARCIA VALENCIA BELEN;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER. Datosregistrales. T 12431 , F 145, S 8, H M 197785, I/A 11 ( 1.10.15).
Revocaciones. Apoderado: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 12431 , F 146, S 8, H M 197785, I/A 12 (1.10.15).
14 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 111 - LOCALES 2 Y 3 (MADRID). Datos registrales. T 12431 , F 145, S8, H M 197785, I/A 10 ( 4.06.12).
09 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5,06 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.000,00 Euros. Datos registrales. T 12431 , F 145, S 8, H M 197785, I/A 9 (30.01.12).
21 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA RODRIGUEZ URBANO JOSE. Datos registrales. T 12431 , F 143, S 8, H M 197785,I/A 8 ( 9.02.11).
11 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Datos registrales. T 12431 , F142, S 8, H M 197785, I/A 6 (26.02.10).
Nombramientos. Apoderado: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 12431 , F 142, S 8, H M 197785, I/A 7(26.02.10).