Actos BORME de Maersk Logistics & Services Spain Sl
17 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44955 , F 22, S 8, H M 388471, I/A101 (10.11.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA CARRILLO ROSANA;GNECCO ELVIO. Datos registrales. T 44955 , F 23, S 8, H M 388471, I/A102 (10.11.23).
21 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: SEPPEY OLIVER KJAERGAARD. Apoderado: FLEISCHER BARBARA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MARIN CALDERON JAVIER. Apo.Manc.: RODRIGUEZ VALVERDE ASCENSION. Datos registrales. T 44955 , F 20,S 8, H M 388471, I/A 99 (14.06.23).
14 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA CRUZ MESONERO EMILIO. Datos registrales. T 42646 , F 29, S 8, H M 388471, I/A 97 (9.04.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERDONES MONTERO DIEGO. Presidente: PERDONES MONTERO DIEGO. Nombramientos.Consejero: DE LA CRUZ MESONERO EMILIO. Presidente: DE LA CRUZ MESONERO EMILIO. Datos registrales. T 44955 , F 20, S8, H M 388471, I/A 98 ( 9.04.23).
07 de Marzo de 2023Ampliacion del objeto social. Las actividades relacionadas con todo tipo de operaciones de almacenamiento, depósito, transportenacional e internacional de mercancías y contenedores, ya sea por vía marítima, aérea, terrestre o férrea, así como el control desuministro de mercancías... Datos registrales. T 42646 , F 29, S 8, H M 388471, I/A 96 (28.02.23).
08 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LLADRO ALFARO MARIA VANESSA;CALVO SIERRA JUAN CARLOS;GUTIERREZ TOCA IRENE.Datos registrales. T 42646 , F 28, S 8, H M 388471, I/A 95 ( 1.02.23).
29 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: RUBIO CORMENZANA DIEGO SANTIAGO. Datos registrales. T 42646 , F 28, S 8, H M 388471, I/A 94(21.12.22).
28 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: TARRYN GOPAUL ILZE. Datos registrales. T 42646 , F 26, S 8, H M 388471, I/A 92 (20.12.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SEPPEY OLIVER KJAERGAARD. Nombramientos. Consejero: TARRYN GOPAUL ILZE. Datosregistrales. T 42646 , F 27, S 8, H M 388471, I/A 93 (20.12.22).
24 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE UBIETA AMIEVA ALBERTO;LOPEZ-MENENDEZ ARQUEROS AMPARO;GARCIACARRILLO ROSANA. Datos registrales. T 42646 , F 26, S 8, H M 388471, I/A 91 (17.11.22).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: FLEISCHER BARBARA. Datos registrales. T 42646 , F 24, S 8, H M 388471, I/A 90 (16.11.22).
10 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: RUBIO CORMENZANA DIEGO SANTIAGO. Datos registrales. T 42646 , F 23, S 8, H M 388471, I/A87 ( 3.10.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: ROCA HELOISE CASSIOPEE. Datos registrales. T 42646 , F 23, S 8, H M 388471, I/A 88 ( 3.10.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: GNECCO ELVIO. Datos registrales. T 42646 , F 24, S 8, H M 388471, I/A 89 ( 3.10.22).
06 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: ESTELLES MARTINEZ ALBERTO. Datos registrales. T 42646 , F 22, S 8, H M 388471, I/A 86(29.06.22).
20 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: ESTELLES MARTIN ALBERTO;MORATINOS COLLANTES EVARISTO RUBEN. Nombramientos.Apo.Sol.: GONZALEZ DE UBIETA AMIEVA ALBERTO. Datos registrales. T 42646 , F 22, S 8, H M 388471, I/A 85 (12.05.22).
22 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRANCO GOMEZ DANIEL. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ NAVEROS TONI. Datosregistrales. T 42646 , F 20, S 8, H M 388471, I/A 83 (15.03.22).
Nombramientos. Apoderado: BENITEZ PECINO ALVARO. Datos registrales. T 42646 , F 21, S 8, H M 388471, I/A 84 (15.03.22).
16 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LOPERA MERINO CELIA. VsecrNoConsj: GONZALEZ DE UBIETA AMIEVA ALBERTO.Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ DE UBIETA AMIEVA ALBERTO. VsecrNoConsj: LOPEZ-MENENDEZ ARQUEROSAMPARO. Datos registrales. T 42646 , F 20, S 8, H M 388471, I/A 82 ( 9.03.22).
01 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ NAVEROS TONI. Datos registrales. T 21805 , F 134, S 8, H M 388471, I/A 81 (24.11.21).
02 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: ROS GALLEGO ROCIO. Datos registrales. T 21805 , F 134, S 8, H M 388471, I/A 80 (25.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GOMEZ CARMEN. Datos registrales. T 21805 , F 134, S 8, H M 388471, I/A 79(19.10.21).
30 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: PEINADO GORDON CRISTINA;BARDIA ESPINOLA ALEX. Datos registrales. T 21805 , F 133, S 8, H M388471, I/A 78 (23.09.21).
17 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GABALDON RIVILLA MARIA;ROCA HELOISE CASSIOPEE;SCHWARTZ JULIE. Datos registrales. T21805 , F 133, S 8, H M 388471, I/A 77 (10.08.21).
01 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: ALEJANDRO PRATOLA ESTEBAN. Nombramientos. Apoderado: MANJON GOMEZ EVA MARIA.Datos registrales. T 21805 , F 132, S 8, H M 388471, I/A 76 (24.06.21).
01 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: ARIAS MANRIQUE EDUARDO ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: ALEJANDRO PRATOLAESTEBAN. Datos registrales. T 21805 , F 131, S 8, H M 388471, I/A 75 (22.02.21).
22 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21805 , F 131, S 8, H M 388471,I/A 74 (15.02.21).
24 de Noviembre de 2020Otros conceptos: El Consejero y Apoderado de la Compañía DON OLIVER KJAERGAARD DAHLSTROEM, manifiesta que suapellido era DAHLSTROEM y con fecha 26 de junio de 2020, ha cambiado su apellido por el de SEPPEY. Datos registrales. T 21805, F 131, S 8, H M 388471, I/A 73 (17.11.20).
27 de Agosto de 2020Modificaciones estatutarias. Se incluye el artículo 17 BIS en los estatutos sociales, relativo a la adopción de acuerdos del Consejode Administración por escrito y sin sesión. Datos registrales. T 21805 , F 131, S 8, H M 388471, I/A 72 (20.08.20).
27 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: MORATINOS COLLANTES EVARISTO RUBEN. Nombramientos. Consejero: KJAERGAARDDAHLSTROEM OLIVER. Datos registrales. T 21805 , F 130, S 8, H M 388471, I/A 71 (20.07.20).
14 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: KJAERGAARD DAHLSTROEM OLIVER. Datos registrales. T 21805 , F 129, S 8, H M 388471, I/A70 ( 7.07.20).