Actos BORME de Magus Creativa Europe Sl
14 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: RODRIGA脩EZ CASADO RAMON. Datos registrales. T 29465 , F 199, S 8, H M 363598, I/A 27 (4.06.12).
15 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: HERNANDO GONZALO RAFAEL MARIA. Datos registrales. T 27022 , F 199, S 8, H M 363598, I/A26 ( 3.02.12).
06 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: HERNANDO GONZALO RAFAEL MARIA. Consejero: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA;RODRIGA脩EZ CASADO RAMON;LOSANTOS EGEA DANIEL. Cons.Del.Sol: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA;RODRIGA脩EZ CASADO RAMON. Presidente: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA. Consejero: LOSANTOSSANTORROMAN MARIA DE LOS ANGELES;LOSANTOS SANTORROMAN MARIA-JOSE. Revocaciones. Auditor: LAES NEXIAAUDITORES SL. Nombramientos. Adm. Unico: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA. Auditor: AUREN AUDITORESMADRID SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 27022 , F 199, S 8, H M 363598, I/A 25 (25.01.12).
24 de Mayo de 2011Nombramientos. Consejero: LOSANTOS SANTORROMAN MARIA DE LOS ANGELES;LOSANTOS SANTORROMAN MARIA-JOSE.Cambio de domicilio social. C/ JULIO REY PASTOR 17 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 27022 , F 199,S 8, H M 363598, I/A 24 (13.05.11).
28 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 23.374.644,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.377.650,00 Euros. Datos registrales. T 27022 , F 197,S 8, H M 363598, I/A 23 (16.02.11).
08 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Cons.Del.Man: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL.Consejero: MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA. Secretario: MEDINA SANCHEZ ROSA. Consejero: ASCLEPIODOTO SL. Presidente:ASCLEPIODOTO SL. Con.Delegado: ASCLEPIODOTO SL. Representan: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA.Revocaciones. Apoderado: MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA. Apo.Sol.: MEDINA SANCHEZ ROSA;LAGARES GOMEZ-ABASCALMANUEL. Nombramientos. Consejero: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA;RODRIGA脩EZ CASADO RAMON;LOSANTOSEGEA DANIEL. Cons.Del.Sol: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA;RODRIGA脩EZ CASADO RAMON. Presidente:LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA. Secretario: HERNANDO GONZALO RAFAEL MARIA. Datos registrales. T 27022 , F196, S 8, H M 363598, I/A 22 (27.01.11).
28 de Junio de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.147.066,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.942.670,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 14.942.670,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.006,00 Euros. ResultanteSuscrito: 3.006,00 Euros. Datos registrales. T 27022 , F 195, S 8, H M 363598, I/A 21 (14.06.10).
27 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: RODRIGA脩EZ CASADO RAMON. Datos registrales. T 27022 , F 195, S 8, H M 363598, I/A 19(17.05.10).
Nombramientos. Apoderado: LANUZA AGUILERA NATALIA;VAQUERO VAQUERO LUIS RAMON. Datos registrales. T 27022 , F195, S 8, H M 363598, I/A 20 (17.05.10).
20 de Abril de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.384.102,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.795.604,00 Euros. Datos registrales. T 27022 , F 193,S 8, H M 363598, I/A 18 ( 8.04.10).
12 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. 11. CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS.-. Datos registrales. T 27022 , F 193, S 8, H M 363598, I/A17 ( 2.03.10).
11 de Marzo de 2010Nombramientos. Presidente: ASCLEPIODOTO SL. Con.Delegado: ASCLEPIODOTO SL. Datos registrales. T 27022 , F 192, S 8, HM 363598, I/A 16 ( 1.03.10).
09 de Marzo de 2010Nombramientos. Auditor: LAES NEXIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 27022 , F 192, S 8, H M 363598, I/A 15 (26.02.10).
16 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: NEINVER SA. Presidente: NEINVER SA. Cons.Del.Man: NEINVER SA. Representan: LOSANTOSSANTORROMAN JOSE-MARIA. Nombramientos. Consejero: ASCLEPIODOTO SL. Representan: LOSANTOS SANTORROMANJOSE-MARIA. Datos registrales. T 27022 , F 192, S 8, H M 363598, I/A 14 ( 4.02.10).
07 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.100.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.411.502,00 Euros. Datos registrales. T 27022 , F 190, S8, H M 363598, I/A 13 (25.11.09).
16 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Nombramientos. Secretario: MEDINA SANCHEZ ROSA.Datos registrales. T 20542 , F 109, S 8, H M 363598, I/A 11 ( 6.10.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA SANCHEZ ROSA;LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Datos registrales. T 20542 , F 109,S 8, H M 363598, I/A 12 ( 6.10.09).
04 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BENZAITEN INVERSIONES SL. Cons.Del.Man: BENZAITEN INVERSIONES SL. Representan:CARBALLO GARCIA LUIS JAVIER. Nombramientos. Consejero: MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 20542 ,F 108, S 8, H M 363598, I/A 8 (25.08.09).
Revocaciones. Apoderado: CARBALLO GARCIA LUIS JAVIER. Datos registrales. T 20542 , F 108, S 8, H M 363598, I/A 9(25.08.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA. Datos registrales. T 20542 , F 109, S 8, H M 363598, I/A10 (25.08.09).
18 de Febrero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.305.216,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.311.302,00 Euros. Datos registrales. T 20542 , F 107, S8, H M 363598, I/A 7 ( 5.02.09).
16 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: TALLADA GARCIA DE LA FUENTE JAVIER. Consejero: RUSTRADUCTUS SL. Secretario:RUSTRADUCTUS SL. Cons.Del.Man: RUSTRADUCTUS SL. Nombramientos. Consejero: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL.Secretario: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Cons.Del.Man: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Datos registrales. T20542 , F 106, S 8, H M 363598, I/A 6 ( 5.02.09).