Actos BORME de Malaga Textil Industrial Del Guadalhorce Sl
24 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Tesorero: FERNANDEZ BERROCAL JOSE ANTONIO;NARANJO DEL RIO FRANCISCO;NARANJO DEL RIOFRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1796/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/11/2018. Auto deconclusi贸n del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 0 DE LO MERCANTIL DE MALAGA. Juez: MARIA DELROCIO MARINA COLL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1796/2014. Fecha de resoluci贸n 3/12/2014. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL DE MALAGA. Juez: MARIA DEL ROCIO MARINA COLL.Administrador Concursal. Fecha 7/11/2018, NIF/CIF 25059169W. SANCHEZ MARTIN JUAN ANTONIO. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 1796/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 7/11/2018. Cese de las limitaciones de las facultades deadministraci贸n. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL DE MALAGA. Juez: MARIA DEL ROCIO MARINA COLL. Extinci贸n. Datosregistrales. T 1870, L 783, F 91, S 8, H MA 25542, I/A 18 (15.01.19).
18 de Febrero de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1796/2014. Fecha de resoluci贸n 3/12/2014. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL DE MALAGA. Juez: MARIA DEL ROCIO MARINA COLL. Administrador Concursal. Fecha3/12/2014, NIF/CIF 25059169W. SANCHEZ MARTIN JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1870, L 783, F 90, S 8, H MA 25542, I/A17 (10.02.15).
02 de Enero de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1796/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 3/12/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 DE LO MERCANTIL DE MALAGA. Juez: MARIA DEL ROCIO MARINA COLL. Datosregistrales. T 1870, L 783, F 90, S 8, H MA 25542, I/A A (23.12.14).
30 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO TEJON ANTONIO. Presidente: MORENO TEJON ANTONIO. Consejero: ALARCONLOPEZ AMPARO. Secretario: ALARCON LOPEZ AMPARO. Tesorero: GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero:GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO. Cons.Del.Man: MORENO TEJONANTONIO;ALARCON LOPEZ AMPARO;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL.Nombramientos. Consejero: ALARCON LOPEZ AMPARO;MORENO TEJON ANTONIO;VALDERRAMA MARTINEZGUILLERMO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Presidente: MORENO TEJON ANTONIO. Vicepresid.: VALDERRAMAMARTINEZ GUILLERMO. Secretario: ALARCON LOPEZ AMPARO. Tesorero: GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL.Cons.Del.Man: MORENO TEJON ANTONIO;ALARCON LOPEZ AMPARO;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO;GONZALEZGONZALEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1870, L 783, F 90, S 8, H MA 25542, I/A 16 (19.09.14).
24 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO TEJON ANTONIO;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO;NARANJO DEL RIOFRANCISCO;ALARCON LOPEZ AMPARO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Presidente: MORENO TEJON ANTONIO.Secretario: ALARCON LOPEZ AMPARO. Cons.Del.Man: MORENO TEJON ANTONIO;VALDERRAMA MARTINEZGUILLERMO;NARANJO DEL RIO FRANCISCO;ALARCON LOPEZ AMPARO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL.Nombramientos. Consejero: MORENO TEJON ANTONIO. Presidente: MORENO TEJON ANTONIO. Consejero: ALARCON LOPEZAMPARO. Secretario: ALARCON LOPEZ AMPARO. Tesorero: GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero: GONZALEZGONZALEZ JUAN MANUEL;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO. Cons.Del.Man: MORENO TEJON ANTONIO;ALARCONLOPEZ AMPARO;VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Cambio de domicilio social.C/ ANTONIO BAENA GOMEZ 2 1潞 A (MALAGA). Datos registrales. T 1870, L 783, F 89, S 8, H MA 25542, I/A 15 (13.09.12).
22 de Febrero de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 37.887,04 Euros. Resultante Suscrito: 2.126.494,26 Euros. Otros conceptos:Renumeraci贸n de las participaciones sociales de la 1 a la 353826, ambas inclusive, por reducci贸n de capital y amortizaci贸n departicipaciones. Datos registrales. T 1870, L 783, F 89, S 8, H MA 25542, I/A 14 ( 8.02.10).
22 de Julio de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100,03 Euros. Resultante Suscrito: 4.966.676,02 Euros. Datos registrales. T 1870, L 783,F 87, S 8, H MA 25542, I/A 10 ( 9.07.09).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.802.294,72 Euros. Resultante Suscrito: 2.164.381,30 Euros. Otros conceptos:Renumeraci贸n de participaciones sociales del 1 al 360130, por reducci贸n del capital social. Datos registrales. T 1870, L 783, F 88, S8, H MA 25542, I/A 11 ( 9.07.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ SAEZ MANUEL. Cons.Del.Man: MARQUEZ SAEZ MANUEL. Consejero: GONZALEZGONZALEZ JUAN MANUEL. Cons.Del.Man: GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero: MORENO TEJON ANTONIO.Cons.Del.Man: MORENO TEJON ANTONIO. Presidente: MORENO TEJON ANTONIO. Consejero: VALDERRAMA MARTINEZ
Reelecciones. Tesorero: NARANJO DEL RIO FRANCISCO. Consejero: MORENO TEJON ANTONIO;VALDERRAMA MARTINEZGUILLERMO;NARANJO DEL RIO FRANCISCO;ALARCON LOPEZ AMPARO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL. Presidente:MORENO TEJON ANTONIO. Secretario: ALARCON LOPEZ AMPARO. Cons.Del.Man: MORENO TEJON ANTONIO;VALDERRAMAMARTINEZ GUILLERMO;NARANJO DEL RIO FRANCISCO;ALARCON LOPEZ AMPARO;GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL.Datos registrales. T 1870, L 783, F 89, S 8, H MA 25542, I/A 13 ( 9.07.09).