Buscador CIF Logo

Actos BORME Management Focus Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Management Focus Sa

Actos BORME Management Focus Sa - A83202358

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Management Focus Sa con CIF A83202358

馃敊 Perfil de Management Focus Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Management Focus Sa

09 de Mayo de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HSM GROUP LLC. Datos registrales. T 37856 , F 188, S 8, H M 297449, I/A 40(28.04.23).

18 de Abril de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.117.123,00 Euros. Resultante Suscrito: 566.590,00 Euros. Datos registrales. T 37856 ,F 188, S 8, H M 297449, I/A 39 ( 7.04.22).

26 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: SAIZ ARESES ALBERTO;REDONDO ALVAREZ PAULA. Datos registrales. T 37856 , F 187, S 8, H M297449, I/A 38 (19.10.21).

16 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ ARAUJO GABRIEL ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: SAIZ ARESESALBERTO. Datos registrales. T 37856 , F 187, S 8, H M 297449, I/A 37 ( 9.04.21).

25 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANZ TRUJILLO PEDRO JOSE. Datos registrales. T 37856 , F 185, S 8, H M 297449, I/A 36(18.02.21).

03 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANZ TRUJILLO PEDRO. Datos registrales. T 37856 , F 185, S 8, H M 297449, I/A 35 (27.08.20).

12 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARCIA GUSTAVO-JAVIER;GATA NU脩EZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: SAIZARESES ALBERTO;HERNANDEZ GOMEZ DANIEL;SANCHEZ ARAUJO GABRIEL ANTONIO;REDONDO ALVAREZPAULA;FERRANDIZ IBA脩EZ MARIA DOLORES. Cambio de domicilio social. C/ OCHANDIANO 8 2 - OFICINA IZQUIERDA(MADRID). Datos registrales. T 17340 , F 224, S 8, H M 297449, I/A 34 ( 5.09.18).

12 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARCIA GUSTAVO-JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ ARAUJO GABRIELANTONIO. Datos registrales. T 17340 , F 224, S 8, H M 297449, I/A 33 (30.11.17).

02 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROSSI ALEXANDER ROGER. Presidente: ROSSI ALEXANDER ROGER. Consejero: ZESATIGONZALEZ HUMBERTO;DAVILA GUZMAN MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: DAVILA GUZMAN MIGUEL ANGEL. SecreNoConsj: GILHERMIDA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: BARCIA GUSTAVO-JAVIER. Modificaciones estatutarias. Modificados losart铆culos 11, 14 y 21 de los estatutos sociales, e incluido el nuevo art铆culo 19bis.. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 17340 , F 221, S 8, H M 297449, I/A 31(22.11.16).

Revocaciones. Apoderado: GIL HERMIDA DIEGO;MARTINEZ THOMPSON MARIANA. Apo.Man.Soli: MANCILLA RIVERADIMITRI;GIL HERMIDA DIEGO;MARTINEZ THOMPSON MARIANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAIZ ARESESALBERTO;GATA NU脩EZ JOSE ANTONIO;SANCHEZ ARAUJO GABRIEL ANTONIO. Datos registrales. T 17340 , F 222, S 8, H M297449, I/A 32 (22.11.16).

21 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apoderado: AZUAGA ENRIQUE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUISMARIA;AZUAGA ENRIQUE;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;RAIMONDI MAXIMILIANO HERNAN;SANCHEZ ARIASDAVID;FERRANDIZ IBA脩EZ MARIA DOLORES;GUIRAO SAGI-VELA GONZALO RAFAEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARCIAGUSTAVO-JAVIER;MANCILLA RIVERA DIMITRI;GIL HERMIDA DIEGO;MARTINEZ THOMPSON MARIANA. Datos registrales. T17340 , F 219, S 8, H M 297449, I/A 30 (13.08.15).

17 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MURRAY PABLO. Vicepresid.: MURRAY PABLO. Consejero: MARTIN LOMANTO EDUARDO.Presidente: MARTIN LOMANTO EDUARDO. Consejero: SAJAROFF MARCELO ALEJANDRO;FIORITO TOMAS MARCOS.Nombramientos. Consejero: ROSSI ALEXANDER ROGER. Presidente: ROSSI ALEXANDER ROGER. Consejero: ZESATIGONZALEZ HUMBERTO;DAVILA GUZMAN MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: DAVILA GUZMAN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T17340 , F 219, S 8, H M 297449, I/A 29 (10.08.15).

09 de Marzo de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 619.075,00 Euros. Desembolsado: 619.075,00 Euros. Resultante Suscrito: 772.974,00 Euros.Resultante Desembolsado: 772.974,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 910.739,00 Euros. Desembolsado: 910.739,00 Euros.Resultante Suscrito: 1.683.713,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.683.713,00 Euros. Datos registrales. T 17340 , F 218, S 8, HM 297449, I/A 28 ( 2.03.15).

06 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRUCHOU EDUARDO;DUBOSQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA JULIO;AZUAGAENRIQUE. Presidente: BRUCHOU EDUARDO. Nombramientos. Consejero: MURRAY PABLO. Vicepresid.: MURRAY PABLO.Consejero: MARTIN LOMANTO EDUARDO. Presidente: MARTIN LOMANTO EDUARDO. Consejero: SAJAROFF MARCELOALEJANDRO;FIORITO TOMAS MARCOS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio dedomicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 135 - 2潞-B (MADRID). Datos registrales. T 17340 , F 217, S 8, H M 297449, I/A 27(26.02.15).

19 de Febrero de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 38.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 153.899,00 Euros. Datos registrales. T 17340 , F217, S 8, H M 297449, I/A 26 (11.02.13).

17 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17340 , F 214, S 8, H M 297449,I/A 23 ( 5.07.12).

Ceses/Dimisiones. Secretario: AZUAGA ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: GIL HERMIDA DIEGO. Datos registrales. T17340 , F 214, S 8, H M 297449, I/A 24 ( 5.07.12).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: NIETO BUESO JUAN JOSE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUISMARIA JULIO;IRIGOIN ALFREDO MIGUEL;BARREIRO TRISTAN FERNANDO;AZUAGA ENRIQUE;RAIMONDI MAXIMILIANOHERNAN;ROMERO GIMARAENS ALFONSO;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN. Apo.Sol.: ROMERO GIMARAENSALFONSO;SANCHEZ ARIAS DAVID;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;MORTE EZQUERRO VICTOR;SANCHEZ DE LAMADRIDFOLGUERA ENRIQUE;SOLANA PALACIOS ALEJANDRO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ARIAS DAVID. Apoderado: NIETO BUESOJUAN JOSE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA;IRIGOIN ALFREDO MIGUEL;BARREIROTRISTAN FERNANDO;AZUAGA ENRIQUE;RAIMONDI MAXIMILIANO HERNAN;TASCO FERNANDO;SANCHEZ ARIASDAVID;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;MORTE EZQUERRO VICTOR;SANCHEZ DELAMADRID FOLGUERA ENRIQUE;SOLANA PALACIOS ALEJANDRO. Nombramientos. Apoderado: GIL HERMIDADIEGO;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA;AZUAGA ENRIQUE;MASUCCI MAXIMILIANOMARTIN;RAIMONDI MAXIMILIANO HERNAN;MARTINEZ THOMPSON MARIANA;SANCHEZ ARIAS DAVID;FERRANDIZ IBA脩EZMARIA DOLORES;GUIRAO SAGI-VELA GONZALO RAFAEL. Datos registrales. T 17340 , F 214, S 8, H M 297449, I/A 25 ( 5.07.12).

10 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: NIETO BUESO JUAN JOSE. Presidente: NIETO BUESO JUAN JOSE. Nombramientos. Presidente:BRUCHOU EDUARDO. Datos registrales. T 17340 , F 214, S 8, H M 297449, I/A 22 (28.06.12).

04 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: NICOLAS CAPUTO JORGE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: AZUAGA ENRIQUE. Datosregistrales. T 17340 , F 213, S 8, H M 297449, I/A 21 (22.06.12).

03 de Mayo de 2012
Nombramientos. Presidente: NIETO BUESO JUAN JOSE. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 19 LAPUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE DON JUAN JOSE NIETO BUESO. Datos registrales. T 17340 , F213, S 8, H M 297449, I/A 19 ( 9.07.10).

16 de Noviembre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ ROSARIO PINO 14-16 4潞 - IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 17340 , F 213, S 8, H M297449, I/A 20 ( 3.11.10).

21 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: NIETO BUESO JUAN JOSE. Presidente: NIETO BUESO JUAN JOSE. Consejero: BRUCHOUEDUARDO;DUBOSCQ NELSON DAMIAN;IRIGOIN ALFREDO MIGUEL;BARREIRO TRISTAN FERNANDO;SAGUIER LUIS MARIAJULIO. Secretario: AZUAGA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: NIETO BUESO JUAN JOSE;BRUCHOUEDUARDO;DUBOSCQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA JULIO;NICOLAS CAPUTO JORGE ANTONIO. Secretario: AZUAGAENRIQUE. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 21. Duraci贸n.-. Datos registrales. T 17340 , F 213, S 8, H M297449, I/A 19 ( 9.07.10).

27 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: NIETO BUESO JUAN JOSE;SAIZ ARESES ALBERTO. Apo.Man.Soli: SAIZ ARESES ALBERTO.Apo.Sol.: SAIZ ARESES ALBERTO;GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE;PERALES NAVAS FERNANDO;SOLDI ROSENTHALFRANCO. Nombramientos. Apoderado: ROMERO GUIMARAENS ALFONSO;NIETO BUESO JUAN JOSE;NIETO BUESO JUANJOSE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSCQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA;IRIGOIN ALFREDO MIGUEL;BARREIROTRISTAN FERNANDO;AZUAGA ENRIQUE;RAIMONDI MAXIMILIANO HERNAN;TASCO FERNANDO;ROMERO GUIMARAENSALFONSO;SANCHEZ ARIAS DAVID;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;TASCO FERNANDO;ROMERO GUIMARAENSALFONSO;SANCHEZ ARIAS DAVID;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;MORTE EZQUERRO VICTOR;SANCHEZ DE LAMADRIDFOLGUERA ENRIQUE;SOLANA PALACIOS ALEJANDRO;TASCO FERNANDO;ROMERO GUIMARAENS ALFONSO. Datosregistrales. T 17340 , F 208, S 8, H M 297449, I/A 18 (15.04.10).

10 de Junio de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARREIRO TRISTAN FERNANDO;NIETO BUESO JUAN JOSE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSCQNELSON DAMIAN;SAIZ ARESES ALBERTO;AZUAGA ENRIQUE;MARCELINO CAPUTO JOSE LUIS;GRANDA ALCON CIRORODRIGO;VOZZA GABRIEL LUIS;NOVOA PABLO ALEJANDRO;CAVANNA CARLOS ROBERTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:NIETO BUESO JUAN JOSE;BRUCHOU EDUARDO;DUBOSCQ NELSON DAMIAN;SAGUIER LUIS MARIA JULIO;IRIGOIN ALFREDOMIGUEL;BARREIRO TRISTAN FERNANDO;AZUAGA ENRIQUE;RAIMONDI MAXIMILIANO HERNAN;SAIZ ARESESALBERTO;ROMERO GIMARAENS ALFONSO;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN. Apo.Sol.: SAIZ ARESES ALBERTO;ROMEROGIMARAENS ALFONSO;SANCHEZ ARIAS DAVID;MASUCCI MAXIMILIANO MARTIN;MORTE EZQUERRO VICTOR;GONZALEZGARCIA JUAN JOSE;PERALES NAVAS FERNANDO;SANCHEZ DE LAMADRID FOLGUERA ENRIQUE;SOLANA PALACIOSALEJANDRO;SOLDI ROSENTHAL FRANCO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ARIAS DAVID. Datos registrales. T 17340 , F 205, S 8, H M297449, I/A 17 (28.05.09).

05 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: NIETO BUESO JUAN JOSE;SAIZ ARESES ALBERTO. Datos registrales. T 17340 , F 205, S 8, H M297449, I/A 16 (27.05.09).

26 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAGUIER LUIS;MARCELINO CAPUTO JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: SAGUIER LUISMARIA JULIO. SecreNoConsj: AZUAGA ENRIQUE. Reelecciones. Consejero: NIETO BUESO JUAN JOSE. Presidente: NIETOBUESO JUAN JOSE. Consejero: BRUCHOU EDUARDO;DUBOSCQ NELSON DAMIAN;IRIGOIN ALFREDO MIGUEL;BARREIROTRISTAN FERNANDO. Datos registrales. T 17340 , F 204, S 8, H M 297449, I/A 15 (14.05.09).

15 de Abril de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17340 , F 204, S 8, H M 297449,I/A 14 (31.03.09).

13 de Marzo de 2009
Cambio de domicilio social. C/ MUSGO 2 2潞 E (MADRID). Datos registrales. T 17340 , F 204, S 8, H M 297449, I/A 13 ( 3.03.09).

23 de Febrero de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 192.374,00 Euros. Datos registrales. T 17340 , F203, S 8, H M 297449, I/A 12 (11.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n