Actos BORME de Manantiales Del Portell Sociedad Anonima
22 de Diciembre de 2022Reelecciones. Consejero: AQUAPLUS SL. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Consejero: NOVACTIS SL. Datosregistrales. T 1555, L 1117, F 222, S 8, H CS 32697, I/A 22 (15.12.22).
03 de Diciembre de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el art铆culo 2潞 de los Estatutos Sociales por ampliaci贸n del objetosocial. Cambio de objeto social. a) La obtenci贸n, preparaci贸n y envasado de aguas minerales de mesa y naturales. b) Lafabricaci贸n de envases pl谩sticos. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 222, S 8, H CS 32697, I/A 21 (26.11.21).
28 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 222, S 8, H CS 32697, I/A 20(15.01.20).
19 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL. Apoderado: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 1555, L 1117, F 222, S 8, H CS 32697, I/A 19 ( 8.08.19).
05 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SELVA DE INZA INVERSIONES SL. Nombramientos. Apoderado: BORDILLS MONTERO PABLO.Consejero: TEMAF INVERSIONES Y NEGOCIOS SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 221, S 8, H CS 32697, I/A 18 (25.02.19).
28 de Noviembre de 2017Reelecciones. Consejero: SELVA DE INZA INVERSIONES SL;FELIX LAVECH SL. Presidente: FELIX LAVECH SL. Datosregistrales. T 1555, L 1117, F 221, S 8, H CS 32697, I/A 17 (20.11.17).
23 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 220, S 8, H CS 32697, I/A16 (14.02.17).
13 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 220, S 8, H CS 32697, I/A 14( 2.12.16).
15 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALMENAR MANTECA FELIPE. Vicepresid.: ALMENAR MANTECA FELIPE. Consejero: LAFUENTEFAYOS MARIA JOSEFA. Nombramientos. Consejero: AQUAPLUS SL;NOVACTIS SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 220, S8, H CS 32697, I/A 13 ( 7.06.16).
04 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALMENAR LAFUENTE IGNACIO FELIPE. Nombramientos. SecreNoConsj: ARI脩O SANCHEZIGNACIO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 40.720,78 Euros. Resultante Suscrito: 459.841,16 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR REDUCCION DECAPITAL SOCIAL. MODIFICACION DEL ARTICULO 12 POR MODIFICACION DEL REGIMEN DE MAYORIAS. MODIFICADO ELARTICULO 17 RELATIVO A LA ADOPCION DE ACUERDOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 1555, L 1117, F 219, S 8, H CS 32697, I/A 12 (19.04.16).
01 de Abril de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICADO por inclusi贸n de un p谩rrafo de la retribuci贸n.. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 219,S 8, H CS 32697, I/A 11 (24.03.15).
11 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 16潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 219, S 8, HCS 32697, I/A 10 ( 3.02.15).
21 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ALMENAR MANTECA FELIPE;LAFUENTE FAYOS MARIA JOSEFA;FELIX LAVECH SL;BAMAGASAINVERSIONES SL. Vicepresid.: ALMENAR MANTECA FELIPE. Presidente: FELIX LAVECH SL. Nombramientos. Consejero: FELIXLAVECH SL;ALMENAR MANTECA FELIPE;LAFUENTE FAYOS MARIA JOSEFA;SELVA DE INZA INVERSIONES SL. Presidente:FELIX LAVECH SL. Vicepresid.: ALMENAR MANTECA FELIPE. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 130, S 8, H CS 32697, I/A 9(10.04.14).
20 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: BAMAGASA INVERSIONES SL;NOVACTIS SL;AQUAPLUS SL;FELIX LAVECH SL. Apo.Man.Soli:SORIANO SORIANO JUAN MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: ALMENAR MANTECA FELIPE;ALMENAR LAFUENTEIGNACIO FELIPE;FELIX REAL FEDERICO;MAIQUES SELVA JOSE MARIA. Apo.Man.Soli: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL.Datos registrales. T 1555, L 1117, F 129, S 8, H CS 32697, I/A 8 (11.12.13).
Nombramientos. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 129, S 8, H CS 32697, I/A7 (11.12.13).
21 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: AQUAPLUS SL. Secretario: AQUAPLUS SL. Consejero: NOVACTIS SL. Vicepresid.: NOVACTIS SL.Nombramientos. Consejero: ALMENAR MANTECA FELIPE;LAFUENTE FAYOS MARIA JOSEFA. SecreNoConsj: ALMENARLAFUENTE IGNACIO FELIPE. Vicepresid.: ALMENAR MANTECA FELIPE. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 16潞de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 129, S 8, H CS 32697, I/A 6 (14.08.13).
24 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 155.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 344.841,94 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 155.720,00 Euros. Desembolsado: 155.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.561,94 Euros. Resultante Desembolsado:500.561,94 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 5潞 de los Estatutos por reducci贸n yposterior ampliaci贸n del capitalsocial. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 128, S 8, H CS 32697, I/A 5 (14.02.12).
19 de Octubre de 2011Nombramientos. Auditor: JUAN CARLOS TOMAS-AUDITORES SL. Datos registrales. T 1555, L 1117, F 128, S 8, H CS 32697, I/A4 (10.10.11).
03 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL;ALMENAR LAFUENTE IGNACIO. Apo.Manc.: SORIANOSORIANO JUAN MANUEL;CAMPOS MARTINEZ VICENTE. Nombramientos. Apo.Manc.: NOVACTIS SL;AQUAPLUS SL;FELIXLAVECH SL;BAMAGASA INVERSIONES SL. Apo.Man.Soli: SORIANO SORIANO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1555, L1117, F 127, S 8, H CS 32697, I/A 3 (25.01.11).
14 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ALMENAR MANTECA FELIPE. Presidente: ALMENAR MANTECA FELIPE. Consejero: ALMENARMANTECA FELIPE;FELIX REAL FEDERICO. Vicepresid.: FELIX REAL FEDERICO. Consejero: O NEILL DE TYRONE DANEYKOARTURO CESAR. Secretario: O NEILL DE TYRONE DANEYKO ARTURO CESAR. Consejero: ALMENAR LAFUENTE IGNACIOFELIPE. Cons.Del.Sol: ALMENAR LAFUENTE IGNACIO FELIPE. Nombramientos. Presidente: FELIX LAVECH SL. Consejero:FELIX LAVECH SL;NOVACTIS SL. Vicepresid.: NOVACTIS SL. Consejero: AQUAPLUS SL. Secretario: AQUAPLUS SL. Consejero:BAMAGASA INVERSIONES SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: TRASLADO DOMICILIO. MOD.ART..MODIFICADO ARTICULO 12.MODIFICADO EL ARTICULO 17.MODIFICADO ARTICULO 16. Cambio de domicilio social.POLIG 10 PARCELA 514 (CHOVAR). Datos registrales. T 1555, L 1117, F 126, S 8, H CS 32697, I/A 2 ( 3.01.11).
17 de Septiembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 856.085,64 Euros. Resultante Suscrito: 500.561,94 Euros. Datos registrales. T 4568, L1879, F 137, S 8, H V 27586, I/A 17 ( 8.09.09).
28 de Enero de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.280.656,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.356.647,58 Euros. Datos registrales. T 4568,L 1879, F 136, S 8, H V 27586, I/A 16 (19.01.09).