Actos BORME de Manchalan Sa
12 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Adm. Unico: GRUPO ILUNION S.L. Revocaciones. Apo.Man.Soli: SOLANOIRIGOYEN IGNACIO;AGUILAR BARRON FERNANDO;SUAREZ SAIZ RAQUEL. Apo.Sol.: ARELLANO GONZALEZJORGE;VELASCO RODRIGUEZ JOSE. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Apo.Man.Soli: ARELLANO GONZALEZJORGE;SUAREZ SAIZ RAQUEL;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN;PEDROTE GARCIA FERNANDO;NAVARRO HIGUERAMERCEDES;BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA;REDONDO UTRILLA JESUS. Apoderado: CASADO TORIBIO LAURA;GARCIAALVAREZ RAUL. Apo.Man.Soli: PALMERO MANGADO VIRGINIA;CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS. Disoluci贸n. Fusion.Extinci贸n. Datos registrales. T 591 , F 204, S 8, H GU 2911, I/A 59 (29.11.17).
17 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Cierre provisional de la hoja durante seis meses de conformidad con lo preceptuado en el art铆culo 231.2 delReglamento del Registro Mercantil. Datos registrales. T 591 , F 204, S 8, H GU 2911, I/A 58n ( 9.11.17).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: CASADO TORIBIO LAURA. Datos registrales. T 591 , F 203, S 8, H GU 2911, I/A 55 (13.03.17).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALVAREZ RAUL. Datos registrales. T 591 , F 203, S 8, H GU 2911, I/A 56 (13.03.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PALMERO MANGADO VIRGINIA. Datos registrales. T 591 , F 204, S 8, H GU 2911, I/A 57(13.03.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 591 , F 204, S 8, H GU 2911, I/A 58(14.03.17).
13 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARELLANO GONZALEZJORGE;SUAREZ SAIZ RAQUEL;INGELMO DE LA MATA JOAQUIN;PEDROTE GARCIA FERNANDO;NAVARRO HIGUERAMERCEDES;BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA;REDONDO UTRILLA JESUS. Datos registrales. T 591 , F 202, S 8, H GU 2911,I/A 53 (25.08.16).
12 de Septiembre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO ILUNION S.L. Datos registrales. T 591 , F 201, S 8, H GU 2911, I/A 54(25.08.16).
22 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 591 , F 201, S 8, H GU 2911, I/A 52 (12.01.16).
04 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 591 , F 201, S 8, H GU 2911, I/A 51 (17.12.15).
30 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO ILUNIONS.L. Datos registrales. T 591 , F 200, S 8, H GU 2911, I/A 49 (22.10.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: VELASCO RODRIGUEZ JOSE. Datos registrales. T 591 , F 200, S 8, H GU 2911, I/A 50 (22.10.15).
24 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: FLOR GONZALEZ MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 591 , F 199, S 8, H GU 2911, I/A 47 (5.08.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 591 , F 199, S 8, H GU 2911, I/A 48 ( 5.08.15).
03 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILAR BARRON FERNANDO. Datos registrales. T 591 , F 198, S 8, H GU 2911, I/A 45(19.06.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ SAIZ RAQUEL. Datos registrales. T 591 , F 198, S 8, H GU 2911, I/A 46 (19.06.15).
26 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: INDUSTRIAS TAJO S.COOP. Presidente: INDUSTRIAS TAJO S.COOP. Consejero: TALLERESPROTEGIDOS GUREAK SA;FUNDOSA GRUPO S.A.;MONDRAGON COMPONENTES S.COOP. Nombramientos. Adm. Unico:FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 8潞 de los nuevos estatutos sociales relativo alr茅gimen de restricci贸n a la libre transmisi贸n de las acciones -que se corresponde con el art铆culo 7潞 de los estatutos sociales anteriores-.Se otorga un NUEVO TEXTO DE ESTATUTOS SOCIALES al objeto de adaptarlo a las modificaciones legislativas. Datos registrales.T 552 , F 65, S 8, H GU 2911, I/A 42 (19.06.15).
Revocaciones. Apoderado: HERCE SUSPERREGUI EDUARDO. Apo.D.Gral.: SOLANO IRIGOYEN IGNACIO. Datos registrales. T591 , F 196, S 8, H GU 2911, I/A 43 (19.06.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLANO IRIGOYEN IGNACIO. Datos registrales. T 591 , F 196, S 8, H GU 2911, I/A 44 (19.06.15).
17 de Octubre de 2014Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 552 , F 65, S 8, H GU 2911, I/A 40 ( 3.10.14).
14 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 552 , F 64, S 8, H GU 2911, I/A 37 (10.02.14).
Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 552 , F 64, S 8, H GU 2911, I/A 38 (10.02.14).
20 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: LUIS MARIA IMAZ BERROTARAN. Datos registrales. T 528 , F 205, S 8, H GU 2911, I/A 33 ( 7.07.11).
Nombramientos. Apoderado: HERCE SUSPERREGUI EDUARDO. Datos registrales. T 528 , F 206, S 8, H GU 2911, I/A 34 (7.07.11).
Cambio de objeto social. -Fabricaci贸n, montaje y venta de piezas de inyecci贸n de pl谩stico. -Montajesy manipulados industriales. -Marketing directo y promocional, prospecci贸nde mercados, todo ello mediante v铆a postal, telem谩tica o telef贸nica. -Limpieza,mantenimiento y conservaci贸n de zonas verdes, edificios e instalacio. Datos registrales. T 552 , F 63, S 8, H GU 2911, I/A 35 (7.07.11).
23 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: TALLERES PROTEGIDOS GUREAK SA. Consejero: TALLERES PROTEGIDOS GUREAKSA;INDUSTRIAS TAJO S.COOP.;MONDRAGON COMPONENTES S.COOP. Representan: HERCE SUSPERREGUIEDUARDO;I脩AQUI ALKORTA ANDONEGUI;BERAZA OLABARRIETA MANUEL. Nombramientos. Representan: HERCESUSPERREGUI EDUARDO. Consejero: INDUSTRIAS TAJO S.COOP. Presidente: INDUSTRIAS TAJO S.COOP. Consejero:TALLERES PROTEGIDOS GUREAK SA;FUNDOSA GRUPO S.A.;MONDRAGON COMPONENTES S.COOP. Representan: I脩AQUI
01 de Septiembre de 2010Nombramientos. Consejero: MONDRAGON COMPONENTES S.COOP. Reelecciones. Presidente: TALLERES PROTEGIDOSGUREAK SA. Consejero: TALLERES PROTEGIDOS GUREAK SA;INDUSTRIAS TAJO S.COOP. Datos registrales. T 528 , F 205, S8, H GU 2911, I/A 31 ( 4.08.10).
20 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.182.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.182.500,00 Euros. Datos registrales. T 469 , F 71, S 8, H GU 2911, I/A 29 ( 4.05.09).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Representan: HERCE SUSPERREGUI EDUARDO. Datos registrales. T 469 , F 71, S 8, H GU 2911, I/A 28(26.01.09).
03 de Febrero de 2009Revocaciones. Apod.D.Gral.: RAMOS NAVARRO SANTIAGO. Datos registrales. T 469 , F 69, S 8, H GU 2911, I/A 26 (23.01.09).
Nombramientos. Apod.D.Gral.: SOLANO IRIGOYEN IGNACIO. Datos registrales. T 469 , F 69, S 8, H GU 2911, I/A 27 (23.01.09).