Actos BORME de Manufacturas Aura Sa
11 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: MAROTO TOLEDO FLORA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ CALLE JESUS. Datos registrales. T 30120 , F 37,S 8, H M 152956, I/A 47 ( 4.05.23).
23 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE LA TORRE CRISOGONO. Datos registrales. T 30120 , F 37, S 8, H M 152956, I/A46 (16.12.22).
18 de Abril de 2022Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.manufacturasaura.com. Datos registrales. T 30120 , F 37,S 8, H M 152956, I/A 45 ( 7.04.22).
04 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Nombramientos.Consejero: LOZANO MARTINEZ-ESTELLEZ RAMON. Secretario: LOZANO MARTINEZ-ESTELLEZ RAMON. Datos registrales. T30120 , F 36, S 8, H M 152956, I/A 44 (28.07.20).
12 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Apo.Sol.: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Datos registrales. T30120 , F 35, S 8, H M 152956, I/A 42 ( 5.02.19).
Nombramientos. Apoderado: LOZANO MARTINEZ-ESTELLEZ RAMON. Datos registrales. T 30120 , F 35, S 8, H M 152956, I/A 43
24 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ BLAZQUEZ JAVIER. Datos registrales. T 30120 , F 35, S 8, H M 152956, I/A 41(12.07.18).
25 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ BLAZQUEZ JAVIER. Datos registrales. T 30120 , F 35, S 8, H M 152956, I/A 40(15.06.18).
05 de Junio de 2018Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ DE LA TORRE CRISOGONO. Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ ANGULOSANTIAGO. Presidente: RODRIGUEZ ANGULO SANTIAGO. Con.Delegado: RODRIGUEZ ANGULO SANTIAGO. Consejero:FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Consejero: GUTIERREZ BLAZQUEZ JAVIER. Datosregistrales. T 30120 , F 34, S 8, H M 152956, I/A 39 (28.05.18).
25 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO;RODRIGUEZ CALLE JESUS. Datos registrales. T 30120 , F 34, S 8, H
24 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: MAROTO TOLEDO FLORA. Datos registrales. T 30120 , F 34, S 8, H M 152956, I/A 37 (13.03.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 30120 , F 33, S 8, H M152956, I/A 35 (24.02.15).
Revocaciones. Auditor: BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 30120 , F 33, S 8, H M152956, I/A 36 (24.02.15).
20 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE LUIS. Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LA TORREJOSE LUIS. Datos registrales. T 30120 , F 33, S 8, H M 152956, I/A 34 (12.02.14).
08 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RODRIGUEZ ANGULO SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ ANGULOSANTIAGO. Presidente: RODRIGUEZ ANGULO SANTIAGO. Con.Delegado: RODRIGUEZ ANGULO SANTIAGO. Consejero:FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Secretario: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Consejero: FERNANDEZ DE LA TORRE JOSELUIS;GUTIERREZ BLAZQUEZ JAVIER. Otros conceptos: POR ACUERDO DE LA JUNTA DEL 30 DE MAYO DE 2012, SEMODIFICANY REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 30120 , F 30, S 8, H M 152956, I/A 32 (30.07.12).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 30120 , F 33, S 8, H M 152956, I/A 33(30.07.12).
24 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ PABLO. Datos registrales. T 30120 , F 30, S 8, H M 152956, I/A 31(13.07.12).
23 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: ACCOUNT CONTROL SOCIEDAD DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 9515 , F 224, S 8, H M152956, I/A 30 (12.07.12).
10 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ CALLE JESUS. Datos registrales. T 9515 , F 224, S 8, H M 152956, I/A 29 (26.06.12).
22 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CALLE JESUS. Datos registrales. T 9515 , F 224, S 8, H M 152956, I/A 28 ( 6.10.09).