Actos BORME de Manufacturas Pabose Sa
30 de Agosto de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36228 , F 96, S 8, H B 158025,I/A 25 (22.08.22).
28 de Junio de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36228 , F 96, S 8, H B 158025,I/A 23 (21.06.22).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36228 , F 96, S 8, H B 158025,I/A 24 (21.06.22).
20 de Diciembre de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 324.545,40 Euros. Resultante Suscrito: 324.545,40 Euros. Datos registrales. T 36228 , F95, S 8, H B 158025, I/A 22 (13.12.21).
18 de Noviembre de 2021Revocaciones. APODERAD.SOL: GIMENEZ GELDE GLORIA. APODERADO: GIMENEZ GELDE GLORIA. Datos registrales. T36228 , F 95, S 8, H B 158025, I/A 21 (11.11.21).
02 de Noviembre de 2021Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: PEDRO DIAZ BODEGA. Datos registrales. T 36228 ,F 95, S 8, H B 158025, I/A 20 (22.10.21).
17 de Septiembre de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: DIAZ MARTINEZ MARIA JOSE;DIAZ MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 36228 , F 94,S 8, H B 158025, I/A 19 ( 9.09.21).
05 de Agosto de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. ADM.SOLIDAR.: DIAZ BODEGA PEDRO;GIMENEZ PALLARES JERONIMO. Datosregistrales. T 7600 , F 152, S 8, H B 158025, I/A 16 N (28.07.21).
Nombramientos. ADM.UNICO: DIAZ BODEGA PEDRO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,9 Y10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 7600 , F 152, S 8, H B158025, I/A 18 (28.07.21).
08 de Junio de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 7600 , F 152, S 8, H B 158025,I/A 17 (28.05.20).
20 de Octubre de 2015Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: DIAZ BODEGA PEDRO;GIMENEZ PALLARES JERONIMO. Datos registrales. T 7600 , F 152, S8, H B 158025, I/A 16 ( 9.10.15).
24 de Abril de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ GELDE GLORIA. Datos registrales. T 7600 , F 151, S 8, H B 158025, I/A 15(14.04.14).
29 de Agosto de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 528.888,80 Euros. Desembolsado: 528.888,80 Euros. Resultante Suscrito: 649.090,80 Euros.Resultante Desembolsado: 649.090,80 Euros. Datos registrales. T 7600 , F 150, S 8, H B 158025, I/A 14 (21.08.13).
09 de Mayo de 2013Nombramientos. APODERADO: DIAZ MARTINEZ CARLOS;GIMENEZ GELDE GLORIA. Datos registrales. T 7600 , F 150, S 8, HB 158025, I/A 13 (30.04.13).
19 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. ART.10:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACIONSOCIAL. Datos registrales. T 7600 , F 150, S 8, H B 158025, I/A 12 ( 8.02.13).
14 de Junio de 2011Revocaciones. ADM.CONJUNTO: DIAZ BODEGA PEDRO;GIMENEZ PALLARES JERONIMO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.:DIAZ BODEGA PEDRO;GIMENEZ PALLARES JERONIMO. Modificaciones estatutarias. ARTS.7 Y 9.- CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 7600 , F 150, S 8, H B 158025, I/A 11 ( 3.06.11).