Buscador CIF Logo

Actos BORME Mapa Tours Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mapa Tours Sa

Actos BORME Mapa Tours Sa - A80077407

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Mapa Tours Sa con CIF A80077407

馃敊 Perfil de Mapa Tours Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Mapa Tours Sa

23 de Noviembre de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8, H M 27041, I/A 45 (16.11.23).

29 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIA GARRIDO RAFAEL. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8,H M 27041, I/A 44 (22.08.23).

22 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8, H M 27041, I/A43 (15.11.22).

19 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Presidente: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩AIGNACIO. Nombramientos. Consejero: O脩ATE DE MORA VIRGILIO;ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE. Presidente: MONTESPEREZ EDUARDO. Datos registrales. T 38960 , F 194, S 8, H M 27041, I/A 42 ( 8.04.22).

28 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN. Nombramientos. Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIAGARRIDO RAFAEL. Datos registrales. T 38960 , F 194, S 8, H M 27041, I/A 41 (21.02.22).

10 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN. Datosregistrales. T 38960 , F 193, S 8, H M 27041, I/A 40 ( 2.11.21).

23 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO CUESTA MARIACONCEPCION. Apo.Manc.: NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;ESTEBAN MORALES ARTURO. Datos registrales. T38960 , F 193, S 8, H M 27041, I/A 39 (16.11.20).

11 de Marzo de 2020
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Otros conceptos: REVOCADO EL AUDITORTITULAR Y SUPLENTE PARA LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020. Datos registrales. T 38960 , F 192, S 8, H M 27041, I/A 38 (4.03.20).

23 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ CARLOS;RANCHAL GARCIA JUAN. Secretario: DIAZ GUTIERREZ CARLOS.Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: ESTEBAN MORALES ARTURO. Consejero: MONTESPEREZ EDUARDO. Presidente: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Apoderado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;DIAZGUTIERREZ CARLOS;NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA;NAVARRO CUESTA MARIACONCEPCION;BLANCA GUIJOSA FELIPE;LOPEZ GARCIA JAVIER;SERRANO GRANADO MARIA ISABEL;ESTEBAN MORALESARTURO. Datos registrales. T 19313 , F 220, S 8, H M 27041, I/A 37 (16.09.19).

20 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;PEGATURSA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE.Representan: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: DIAZ GUTIERREZ CARLOS;DIAZ GUTIERREZALBERTO;RANCHAL GARCIA JUAN;CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO.Secretario: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Datos registrales. T 19313 , F 216, S 8, H M 27041, I/A 34 (12.02.19).

Nombramientos. Apoderado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Datos registrales. T 19313 , F 217, S 8, H M 27041, I/A 35 (12.02.19).

Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 19313 , F 219, S 8,H M 27041, I/A 36 (12.02.19).

16 de Octubre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 503.301,26 Euros. Resultante Suscrito: 1.206.014,74 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.- . Datos registrales. T 19313 , F 215, S 8, H M 27041, I/A 33 ( 8.10.18).

30 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 214, S 8, H M 27041, I/A 32 (22.08.18).

27 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Datos registrales. T 19313 , F 214, S 8, H M 27041, I/A 31 (17.11.17).

27 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 213, S 8, H M 27041, I/A 29 (13.01.16).

18 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;PEGATURSA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Representan: DIAZ GUTIERREZCARLOS. Nombramientos. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIAJUAN;PEGATUR SA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Representan: DIAZGUTIERREZ CARLOS. Datos registrales. T 19313 , F 213, S 8, H M 27041, I/A 28 ( 9.09.14).

19 de Diciembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.709.316,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.709.316,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 27 (11.12.12).

16 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 26 ( 5.11.12).

09 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RANCHAL GARCIA CARMEN;CARO CARMONA JOSE LUIS. Datos registrales. T 19313 , F 211, S8, H M 27041, I/A 23 (30.07.12).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 285.000,00 Euros. Desembolsado: 285.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.071.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.071.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 24 (30.07.12).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 237.441,00 Euros. Desembolsado: 237.441,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.309.316,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.309.316,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 25 (30.07.12).

26 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 22 (16.07.12).

23 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Consejero: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Nombramientos. Secretario:BLANCA GUIJOSA FELIPE. Datos registrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 21 (12.12.11).

24 de Mayo de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 786.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 786.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 210, S 8, H M 27041, I/A 20 (12.05.11).

29 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Apo.Manc.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Apo.Sol.: RANCHAL GARCIAJUAN. Apo.Manc.: RANCHAL GARCIA JUAN. Datos registrales. T 19313 , F 209, S 8, H M 27041, I/A 19 (16.03.10).

29 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 200.000,00 Euros. Desembolsado: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 486.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 486.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 209, S 8, H M 27041, I/A 18 (18.09.09).

22 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;BLANCA GUIJOSA FELIPE;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHALGARCIA CARMEN;RANCHAL GARCIA JUAN. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE.Co.De.Ma.So: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;BLANCA GUIJOSA FELIPE.Nombramientos. Representan: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Consejero: BLANCA GUIJOSA FELIPE;DIAZ GUTIERREZALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;RANCHAL GARCIA CARMEN;CARO CARMONA JOSELUIS;PEGATUR SA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Con.Delegado: DIAZ

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n