Actos BORME de Mapa Tours Sa
23 de Noviembre de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8, H M 27041, I/A 45 (16.11.23).
29 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIA GARRIDO RAFAEL. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8,H M 27041, I/A 44 (22.08.23).
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38960 , F 195, S 8, H M 27041, I/A43 (15.11.22).
19 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Presidente: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩AIGNACIO. Nombramientos. Consejero: O脩ATE DE MORA VIRGILIO;ALFONSO SANCHEZ ANTONIO JOSE. Presidente: MONTESPEREZ EDUARDO. Datos registrales. T 38960 , F 194, S 8, H M 27041, I/A 42 ( 8.04.22).
28 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN. Nombramientos. Consejero: SAIZ GONZALEZ ENRIQUE;GARCIAGARRIDO RAFAEL. Datos registrales. T 38960 , F 194, S 8, H M 27041, I/A 41 (21.02.22).
10 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: HORNEDO LOPEZ IBOR JUAN. Datosregistrales. T 38960 , F 193, S 8, H M 27041, I/A 40 ( 2.11.21).
23 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA. Nombramientos. Apoderado: NAVARRO CUESTA MARIACONCEPCION. Apo.Manc.: NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;ESTEBAN MORALES ARTURO. Datos registrales. T38960 , F 193, S 8, H M 27041, I/A 39 (16.11.20).
11 de Marzo de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Otros conceptos: REVOCADO EL AUDITORTITULAR Y SUPLENTE PARA LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020. Datos registrales. T 38960 , F 192, S 8, H M 27041, I/A 38 (4.03.20).
23 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ CARLOS;RANCHAL GARCIA JUAN. Secretario: DIAZ GUTIERREZ CARLOS.Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: ESTEBAN MORALES ARTURO. Consejero: MONTESPEREZ EDUARDO. Presidente: CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Apoderado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;DIAZGUTIERREZ CARLOS;NAVARRO CUESTA MARIA CONCEPCION;MARTIN DE FRUTOS ALMUDENA;NAVARRO CUESTA MARIACONCEPCION;BLANCA GUIJOSA FELIPE;LOPEZ GARCIA JAVIER;SERRANO GRANADO MARIA ISABEL;ESTEBAN MORALESARTURO. Datos registrales. T 19313 , F 220, S 8, H M 27041, I/A 37 (16.09.19).
20 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;PEGATURSA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE.Representan: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: DIAZ GUTIERREZ CARLOS;DIAZ GUTIERREZALBERTO;RANCHAL GARCIA JUAN;CASANOVA SANCHEZ DE OCA脩A IGNACIO. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO.Secretario: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Datos registrales. T 19313 , F 216, S 8, H M 27041, I/A 34 (12.02.19).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Datos registrales. T 19313 , F 217, S 8, H M 27041, I/A 35 (12.02.19).
Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 19313 , F 219, S 8,H M 27041, I/A 36 (12.02.19).
16 de Octubre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 503.301,26 Euros. Resultante Suscrito: 1.206.014,74 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.- . Datos registrales. T 19313 , F 215, S 8, H M 27041, I/A 33 ( 8.10.18).
30 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 214, S 8, H M 27041, I/A 32 (22.08.18).
27 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Datos registrales. T 19313 , F 214, S 8, H M 27041, I/A 31 (17.11.17).
27 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 213, S 8, H M 27041, I/A 29 (13.01.16).
18 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;PEGATURSA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Representan: DIAZ GUTIERREZCARLOS. Nombramientos. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIAJUAN;PEGATUR SA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Con.Delegado: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Representan: DIAZGUTIERREZ CARLOS. Datos registrales. T 19313 , F 213, S 8, H M 27041, I/A 28 ( 9.09.14).
19 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.709.316,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.709.316,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 27 (11.12.12).
16 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 26 ( 5.11.12).
09 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RANCHAL GARCIA CARMEN;CARO CARMONA JOSE LUIS. Datos registrales. T 19313 , F 211, S8, H M 27041, I/A 23 (30.07.12).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 285.000,00 Euros. Desembolsado: 285.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.071.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.071.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 24 (30.07.12).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 237.441,00 Euros. Desembolsado: 237.441,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.309.316,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.309.316,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 212, S 8, H M 27041, I/A 25 (30.07.12).
26 de Julio de 2012Reelecciones. Auditor: ALEMANY HERRERA RAFAEL. Aud.Supl.: AMO MIRON SAN SEGUNDO Y ASOCIADOS SA. Datosregistrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 22 (16.07.12).
23 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Consejero: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Nombramientos. Secretario:BLANCA GUIJOSA FELIPE. Datos registrales. T 19313 , F 211, S 8, H M 27041, I/A 21 (12.12.11).
24 de Mayo de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 786.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 786.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 210, S 8, H M 27041, I/A 20 (12.05.11).
29 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Apo.Manc.: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Apo.Sol.: RANCHAL GARCIAJUAN. Apo.Manc.: RANCHAL GARCIA JUAN. Datos registrales. T 19313 , F 209, S 8, H M 27041, I/A 19 (16.03.10).
29 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 200.000,00 Euros. Desembolsado: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 486.875,00 Euros.Resultante Desembolsado: 486.875,00 Euros. Datos registrales. T 19313 , F 209, S 8, H M 27041, I/A 18 (18.09.09).
22 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;BLANCA GUIJOSA FELIPE;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHALGARCIA CARMEN;RANCHAL GARCIA JUAN. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE.Co.De.Ma.So: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;BLANCA GUIJOSA FELIPE.Nombramientos. Representan: DIAZ GUTIERREZ CARLOS. Consejero: BLANCA GUIJOSA FELIPE;DIAZ GUTIERREZALBERTO;SANZ CORTIJO OSCAR LUIS;RANCHAL GARCIA JUAN;RANCHAL GARCIA CARMEN;CARO CARMONA JOSELUIS;PEGATUR SA. Presidente: DIAZ GUTIERREZ ALBERTO. Secretario: BLANCA GUIJOSA FELIPE. Con.Delegado: DIAZ