Actos BORME de Mar De Frades Sl
07 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3573 , F 147, S 8, H MU 42409, I/A 47 (31.01.23).
18 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER PIJOAN MARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RODOLFO BASTIDA CARO;RAULBORREGUERO MARTIN;PAULA FANDI脩O PITA. Apo.Sol.: JOSE ANTONIO VALES CASAS;QUERUBINA HERNANDEZVIVANCOS;CRISTINA GONZALEZ FERNANDEZ;ALBERTO MIRANDA VALLIN. Datos registrales. T 3573 , F 145, S 8, H MU42409, I/A 46 (11.01.23).
18 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: PAULA FANDI脩O PITA;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Apo.Sol.: ENRIQUE DE COIGO`DONNELL LOPEZ. Apo.Manc.: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;MARIA DEL CARMEN VALLEJO SANCHEZ. Apoderado:MARIA DEL CARMEN GINE DOMINGUEZ;ASCENSION LOPEZ ORTEGA;ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;QUERUBINAHERNANDEZ VIVANCOS;RODOLFO BASTIDA CARO;PAULA FANDI脩O PITA;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS;RAULBORREGUERO MARTIN;PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3573 , F 144, S 8, H MU 42409, I/A 45 (11.08.22).
06 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER PIJOAN MARIN;MONTSERRAT DIEZ RIVAS;RODOLFO BASTIDA CARO;RAULBORREGUERO MARTIN;PAULA FANDI脩O PITA. Apo.Manc.: MARIA DEL CARMEN GINE DOMINGUEZ. Apo.Man.Soli: ENRIQUEDE COIG O`DONNELL LOPEZ;JOSE ANTONIO VALES CASAS;QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS;CRISTINA GONZALEZFERNANDEZ. Datos registrales. T 3196 , F 93, S 8, H MU 42409, I/A 44 (28.04.22).
09 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3196 , F 93, S 8, H MU 42409, I/A 42 ( 2.03.22).
22 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3196 , F 93, S 8, H MU 42409, I/A 41 (15.02.22).
18 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3196 , F 93, S 8, H MU 42409, I/A 40 (11.11.21).
05 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datos registrales. T 3196 , F 92, S 8, H MU 42409, I/A 39(27.04.21).
18 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3196 , F 92, S 8, H MU 42409, I/A 38 (11.12.20).
19 de Diciembre de 2019Fe de erratas: Se public贸 erroneamente el n煤mero de inscripci贸n como 36陋 que corresponde a la fecha de inscripci贸n 3 de abril de2019 siendo lo correcto la inscripci贸n 37陋 con fecha de inscripci贸n 4 de diciembre de 2019.- Datos registrales. T 3196 , F 92, S 8, HMU 42409, I/A 37 ( 4.12.19).
13 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3196 , F 92, S 8, H MU 42409, I/A 36 ( 4.12.19).
10 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3196 , F 91, S 8, H MU 42409, I/A 36 ( 3.04.19).
15 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: RAUL BORREGUERO MARTIN. Datos registrales. T 3196 , F 90, S 8, H MU 42409, I/A 35 ( 8.03.18).
15 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES JOSE AYALA SANCHEZ;JUAN JOSE FANLO GOMEZ. Datos registrales. T 3196 , F 90, S 8,H MU 42409, I/A 34 ( 8.09.17).
19 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3196 , F 90, S 8, H MU 42409, I/A 33(12.07.17).
01 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3196 , F 90, S 8, H MU 42409, I/A 32 (22.02.17).
12 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Datos registrales. T 2778 , F 49, S 8, H MU 42409, I/A 26 (5.09.16).
Nombramientos. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datos registrales. T 3196 , F 84, S 8, H MU 42409, I/A 27( 5.09.16).
Nombramientos. Apoderado: RODOLFO BASTIDA CARO. Datos registrales. T 3196 , F 87, S 8, H MU 42409, I/A 28 ( 5.09.16).
Nombramientos. Apoderado: PAULA FANDI脩O PITA. Datos registrales. T 3196 , F 89, S 8, H MU 42409, I/A 29 ( 5.09.16).
Nombramientos. Apoderado: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ. Datos registrales. T 3196 , F 89, S 8, H MU 42409, I/A 30 (5.09.16).
Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3196 , F 89, S 8, H MU 42409, I/A 31 (5.09.16).
24 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Datos registrales. T 2778 , F 49, S 8, H MU 42409, I/A 25(17.12.14).
03 de Enero de 2013Cambio de domicilio social. C/ SILICIO 10 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS CAMACHOS (CARTAGENA). Datos registrales. T2778 , F 49, S 8, H MU 42409, I/A 24 (27.12.12).
10 de Agosto de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RAMON BILBAO VINOS Y VI脩EDOS SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: EMILIORESTOY CABRERA. Presidente: EMILIO RESTOY ZAMORA. Consejero: RODOLFO BASTIDA CARO. Secretario: CARLOS MATEOPEREZ LLORENTE. Consejero: CARLOS MATEO PEREZ LLORENTE;JOSE GARCIA CONESA;EMILIO RESTOY ZAMORA.Nombramientos. Adm. Unico: DIEGO ZAMORA SA. Apoderado: ASCENSION LOPEZ ORTEGA. Modificaciones estatutarias.
19 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: MARIA DEL CARMEN GINE DOMINGUEZ. Datos registrales. T 2778 , F 48, S 8, H MU 42409, I/A 22( 8.06.12).
10 de Enero de 2011Nombramientos. Consejero: EMILIO RESTOY CABRERA;RODOLFO BASTIDA CARO. Datos registrales. T 2778 , F 48, S 8, H MU42409, I/A 20 (29.12.10).
Revocaciones. Apoderado: EMILIO RESTOY ZAMORA;EMILIO RESTOY ZAMORA. Datos registrales. T 2778 , F 48, S 8, H MU42409, I/A 21 (29.12.10).
26 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: EMILIO RESTOY CABRERA. Datos registrales. T 2400 , F 147, S 8, H MU 42409, I/A 19 (18.11.10).
05 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 2400 , F 146, S 8, H MU 42409, I/A 16(23.12.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ. Apo.Manc.: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;MARIADEL CARMEN VALLEJO SANCHEZ. Datos registrales. T 2400 , F 146, S 8, H MU 42409, I/A 17 (23.12.09).
27 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: EMILIO RESTOY CABRERA. Datos registrales. T 2400 , F 145, S 8, H MU 42409, I/A 16 (18.03.09).