Actos BORME de Maria Baviera Sl
27 de Septiembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 269.999,25 Euros. Resultante Suscrito: 1.009.505,71 Euros. Datos registrales. T 6714, L4018, F 31, S 8, H V 73700, I/A 12 (20.09.22).
24 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: BENLLOCH BAVIERA JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: BENLLOCH BAVIERA MARIAESTHER. Datos registrales. T 6714, L 4018, F 31, S 8, H V 73700, I/A 11 (17.11.21).
02 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ MENENDEZ PELAYO 1 4潞 11 (VALENCIA). Datos registrales. T 6714, L 4018, F 31, S 8, H V73700, I/A 10 (23.02.21).
15 de Enero de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 658.275,30 Euros. Resultante Suscrito: 1.279.504,96 Euros. Datos registrales. T 6714, L4018, F 30, S 8, H V 73700, I/A 9 ( 8.01.18).
25 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. C/ ALVARO DE BAZAN 8 2 3 (VALENCIA). Datos registrales. T 6714, L 4018, F 30, S 8, H V 73700,I/A 8 (18.08.16).
10 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAVIERA MIQUEL MARIA. Nombramientos. Consejero: BENLLOCH BAVIERA MARIAISABEL;BENLLOCH BAVIERA MARIA ESTHER;BENLLOCH BAVIERA JOSE MARIA;BENLLOCH BAVIERA MARIAREMEDIOS;BENLLOCH BAVIERA MARIA AMPARO. Presidente: BENLLOCH BAVIERA JOSE MARIA. Vicepresid.: BENLLOCHBAVIERA MARIA ESTHER. Secretario: BENLLOCH BAVIERA MARIA ISABEL. Con.Delegado: BENLLOCH BAVIERA MARIA ISABEL.Modificaciones estatutarias. Articulo 15 modificado.Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 6714, L 4018, F 29, S 8, H V 73700, I/A 7 ( 2.01.13).
27 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: BENLLOCH BAVIERA MARIA ISABEL;BENLLOCH BAVIERA MARIA ESTHER;BENLLOCH BAVIERAJOSE MARIA;BENLLOCH BAVIERA MARIA AMPARO;BENLLOCH BAVIERA MARIA REMEDIOS. Datos registrales. T 6714, L4018, F 29, S 8, H V 73700, I/A 6 (18.01.12).
12 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: BENLLOCH BAVIERA MARIA ISABEL;BENLLOCH BAVIERA MARIA AMPARO. Datos registrales. T6714, L 4018, F 29, S 8, H V 73700, I/A 5 (30.03.10).