Actos BORME de Mariner Sa
18 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE. Presidente: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE.Consejero: MARINER RANDE JORGE. Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Vicesecret.: MARINER RANDE JORGE. Consejero:MARINER RANDE ALEJANDRO. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Consejero: MARINER TAMARIT MARIO;MARINERTAMARIT OSCAR-FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE;MARINER RANDEJORGE;MARINER RANDE ALEJANDRO;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER TAMARIT MONICA. Presidente: MARINERCOLOMER FRANCISCO JOSE. Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Vicesecret.: MARINER RANDE JORGE. Secretario:MARINER RANDE ALEJANDRO. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 108, S 8, H V 30777, I/A 90 (11.10.23).
23 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VILARNAU LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 107, S 8, H V 30777, I/A89 (16.02.23).
19 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Apoderado: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Apo.Sol.: MARINERMONLEON ENRIQUE;MARINER MONLEON ENRIQUE. Apoderado: MARINER MONLEON MARIO;MARINER MONLEON MARIO.Apo.Sol.: MARINER MONLEON MARIO;MARINER MONLEON MARIO;MARINER MONLEON FRANCISCO;MARINER MONLEONFRANCISCO. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 107, S 8, H V 30777, I/A 88 (12.12.22).
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 6/10/2022. Auto de declaraci贸n decumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA. Juez: JACINTO TALENSSEGUI. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 6/10/2022. Auto de conclusi贸n delconcurso. Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA. Juez: JACINTOTALENS SEGUI. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 6/10/2022. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA. Juez:JACINTO TALENS SEGUI. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 107, S 8, H V 30777, I/A 87 (12.12.22).
16 de Diciembre de 2022Cambio de objeto social. La fabricaci贸n y comercializaci贸n de muebles y l谩mparas, accesorios de decoraci贸n y complementos detoda clase. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 105, S 8, H V 30777, I/A 85 ( 9.12.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE;MARINER RANDE JORGE;MARINER RANDEALEJANDRO;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER TAMARIT OSCAR-FERNANDO. Presidente: MARINER COLOMERFRANCISCO JOSE. Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Vicesecret.: MARINERTAMARIT MARIO. Nombramientos. Consejero: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE. Presidente: MARINER COLOMERFRANCISCO JOSE. Consejero: MARINER RANDE JORGE. Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Vicesecret.: MARINER RANDEJORGE. Consejero: MARINER RANDE ALEJANDRO. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Consejero: MARINER TAMARITMARIO;MARINER TAMARIT OSCAR-FERNANDO. Otros conceptos: Modificados y refundidos los estatutos sociales. Datosregistrales. T 9294, L 6576, F 105, S 8, H V 30777, I/A 86 ( 9.12.22).
02 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: DOLMAR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 104, S 8, H V 30777,I/A 84 (26.07.22).
09 de Mayo de 2019Otros conceptos: La anotaci贸n preventiva letra B, publicada en el Bolet铆n 219 de fecha 17/11/14 y referencia 04663612014, por lacual se tom贸 raz贸n de la aprobaci贸n del convenio de acreedores, ha quedado convertida en la inscripci贸n 81陋 al haber adquiridofirmeza la sentencia aprobatoria del mismo. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha deresoluci贸n 20/10/2014. Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEVALENCIA. Juez: JACINTO TALENS SEGUI. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha deresoluci贸n 20/10/2014. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 2 DE VALENCIA. Juez: JACINTO TALENS SEGUI. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 104, S 8, H V 30777, I/A 81 (2.05.19).
Nombramientos. Auditor: DOLMAR AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.Supl.: GRANT THORNTON SLP. Desembolso dedividendos pasivos. Desembolsado: 304.502,50 Euros. Otros conceptos: MODIFICAR EL ORDINAL DEL ART. 27 DEL CAPITAL
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 26潞 de los estatutos sociales, relativo a la retribuci贸n del 贸rgano deadministraci贸n. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 104, S 8, H V 30777, I/A 83 ( 2.05.19).
20 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: MORENO COLOMO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 104, S 8, H V 30777,I/A 80 (13.03.19).
26 de Julio de 2018Cambio de domicilio social. AVDA ANTIC REGNE DE VALENCIA 27 (ALCASSER). Datos registrales. T 9294, L 6576, F 103, S 8,H V 30777, I/A 79 (19.07.18).
11 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER TAMARIT MONICA;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER COLOMER FRANCISCOJOSE;MARINER RANDE JORGE;MARINER RANDE ALEJANDRO. Presidente: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE.Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Vicesecret.: MARINER TAMARIT MONICA.Nombramientos. Consejero: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE;MARINER RANDE JORGE;MARINER RANDEALEJANDRO;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER TAMARIT OSCAR-FERNANDO. Presidente: MARINER COLOMERFRANCISCO JOSE. Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Vicesecret.: MARINERTAMARIT MARIO. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 103, S 8, H V 30777, I/A 78 ( 4.07.17).
29 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER MONLEON MARIO;MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER;MARINER MONLEONENRIQUE CARLOS. Presidente: MARINER MONLEON MARIO. Secretario: MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: MARINER TAMARIT MONICA;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER COLOMER FRANCISCOJOSE;MARINER RANDE JORGE;MARINER RANDE ALEJANDRO. Presidente: MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE.Vicepresid.: MARINER RANDE JORGE. Secretario: MARINER RANDE ALEJANDRO. Vicesecret.: MARINER TAMARIT MONICA.Datos registrales. T 9294, L 6576, F 103, S 8, H V 30777, I/A 77 (22.06.16).
26 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: MARTINEZ AUDITORES SL. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 102, S 8, H V 30777, I/A 75 (19.05.16).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 25.718.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:609.005,00 Euros. Desembolsado: 304.502,50 Euros. Resultante Suscrito: 609.005,00 Euros. Resultante Desembolsado: 304.502,50Euros. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 102, S 8, H V 30777, I/A 76 (19.05.16).
06 de Abril de 2016P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: infomariner.wordpress.com. Datos registrales. T 9294, L 6576,F 102, S 8, H V 30777, I/A 74 (31.03.16).
10 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER DOMINGO MARIA ENRIQUETA. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 101, S 8, H V30777, I/A 73 ( 3.03.15).
17 de Noviembre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/10/2014. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: JACINTO TALENS SEGUI. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 682/2012. Fecha de resoluci贸n 4/06/2012. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha20/10/2014, NIF/CIF 25404050K. ANDREU LLOPEZ JOSE. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: No,Fecha de resoluci贸n 20/10/2014. Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE VALENCIA. Juez: JACINTO TALENS SEGUI. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 101, S 8, H V 30777, I/A B(10.11.14).
31 de Octubre de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo 14.- Forma de Convocatoria de la Junta: La convocatoria de la Junta General Ordinaria yExtraordinaria y su eventual complemento se realizar谩n mediante anuncio publicado en la p谩gina web de la sociedad una vez creada,inscrita y publicada 茅sta. . Datos registrales. T 9294, L 6576, F 101, S 8, H V 30777, I/A 72 (24.10.14).
04 de Julio de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/05/2014. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: JACINTO TALENS SEGUI. Datos registrales. T9294, L 6576, F 101, S 8, H V 30777, I/A A (27.06.14).
04 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: MARTINEZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 100, S 8, H V 30777, I/A 70(26.03.13).
Nombramientos. Aud.Supl.: EUGENIO MACHANCOSES GONZALEZ. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 100, S 8, H V 30777,I/A 71 (26.03.13).
25 de Julio de 2012Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/06/2012. Solicitud de declaraci贸n.Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 682/2012. Fecha de resoluci贸n 4/06/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha4/06/2012, NIF/CIF 25404050K. ANDREU LLOPEZ JOSE. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME: Si,Fecha de resoluci贸n 4/06/2012. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEVALENCIA. Juez: ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 682/2012. FIRME:Si, Fecha de resoluci贸n 4/06/2012. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n ydisposici贸n del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: ROSA SONSOLES HERNANDEZGONZALEZ. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 100, S 8, H V 30777, I/A 69 (16.07.12).
24 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER. Presidente: MARINER MONLEON MARIO.Revocaciones. Apoderado: LABORDE BOIS MARINER RAFAEL;LAZARO PLA ROBERTO. Nombramientos. Presidente:MARINER MONLEON MARIO. Secretario: MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 100, S8, H V 30777, I/A 68 (13.07.12).
23 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Secretario: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Datos registrales. T9294, L 6576, F 100, S 8, H V 30777, I/A 67 (12.07.12).
21 de Mayo de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: MARINER RANDE ALEJANDRO;MORENO COLOMO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 9294,L 6576, F 99, S 8, H V 30777, I/A 66 ( 9.05.12).
08 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MERI REIG FRANCISCO. Apoderado: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA YNAVEGACION;SITTON SITTON ISAAC. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA JOSE LUIS;MERI REIG FRANCISCO;ESPARZA TORRESEDUARDO;GARRIGUES BALLESTER CARLOS. Apoderado: MARINER SANCHIS ENRIQUE MANUEL;ESTEVE FRANCES JUAN.Apo.Sol.: GARCIA GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 99, S 8, H V 30777, I/A 65 (25.04.12).
14 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARGARIT MARINER ANA MARIA. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 99, S 8, H V 30777, I/A 64( 1.12.11).
17 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 500.000,00 Euros. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.718.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 25.718.500,00 Euros. Datos registrales. T 9294, L 6576, F 99, S 8, H V 30777, I/A 63 ( 4.11.11).
27 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: MARINER RANDE ENRIQUE MARIO. Datos registrales. T 5772, L 3079, F 110, S 8, H V 30777, I/A 62(14.04.11).
07 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER MONLEON ENRIQUE CARLOS. Presidente: MARINER MONLEON ENRIQUE CARLOS.Consejero: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Vicepresid.: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Consejero: MARINER MONLEON MARIO.Secretario: MARINER MONLEON MARIO. Consejero: MARINER DOMINGO MARIA ENRIQUETA;MARINER MONLEON FRANCISCOJAVIER. Vicesecret.: MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER. Consejero: MARGARIT MARINER ANA MARIA. Nombramientos.Consejero: MARINER MONLEON MARIO. Presidente: MARINER MONLEON MARIO. Consejero: MARINER MONLEON FRANCISCOJAVIER. Vicepresid.: MARINER MONLEON FRANCISCO JAVIER. Consejero: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Secretario: MARINERDOMINGO ENRIQUE. Consejero: MARINER DOMINGO MARIA ENRIQUETA;MARGARIT MARINER ANA MARIA;MARINERMONLEON ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 5772, L 3079, F 110, S 8, H V 30777, I/A 61 (27.01.11).
05 de Mayo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 24.412.500,00 Euros. Desembolsado: 24.412.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.218.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 25.218.500,00 Euros. Datos registrales. T 5772, L 3079, F 109, S 8, H V 30777, I/A 60 (23.04.09).
03 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MARINER MONLEON ENRIQUE;MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE;MARINER MONLEONFRANCISCO;MARINER MONLEON MARIO;MARINER DOMINGO ENRIQUE;MARINER DOMINGO MARIA ENRIQUETA;MARGARITBALAGUER MATEO;LABORDE BOIS MARINER RAFAEL;MARINER TAMARIT MARIO;MARINER SANCHIS PABLO;MARGARITMARINER ANA MARIA. Presidente: MARINER MONLEON ENRIQUE. Vicepresid.: MARINER DOMINGO ENRIQUE. Secretario: