Actos BORME de Maritima Alisea Sl
14 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 208, S 8, H V 129552, I/A 26 ( 7.01.19).
10 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: EUDITA CJC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 207, S 8, H V 129552, I/A 25 (3.10.18).
28 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: YAGUE MARTIN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 207, S 8, H V 129552, I/A 24(21.02.17).
07 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LORENTE HEINL MIGUEL AXEL. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 207, S 8, H V 129552, I/A 23(29.11.16).
30 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: CAMACHO MAÑEZ MARIA BEGOÑA. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 207, S 8, H V 129552, I/A22 (23.09.16).
08 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ NUÑEZ 40 - ESQUINA CON CALLE TONELEROS (VALENCIA). Datos registrales. T9470, L 6752, F 206, S 8, H V 129552, I/A 21 ( 1.08.16).
07 de Agosto de 2015Nombramientos. Auditor: EUDITA CJC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 206, S 8, H V 129552, I/A 20(31.07.15).
13 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA RAMIREZ EVA MARIA. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 206, S 8, H V 129552, I/A 19 (6.03.14).
11 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ALVAREZ CRISTINA;JIMENEZ TORAL LAURA. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 205,S 8, H V 129552, I/A 16 ( 4.10.13).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ INFANTE MARIA DE LA PALMA. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 205, S 8, H V129552, I/A 17 ( 4.10.13).
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ CHAFER DESAMPARADOS. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 206, S 8, H V 129552, I/A18 ( 4.10.13).
10 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: GARCIA ABIS AGUSTIN. Apo.Manc.: RAMOS SANCHEZ SILVIA;TELLO BARROSO VICENTE MARIA.Apoderado: ARASSA BARATIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 205, S 8, H V 129552, I/A 15 ( 3.10.13).
15 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: CASTILLO MELIAN RAQUEL. Datos registrales. T 9470, L 6752, F 205, S 8, H V 129552, I/A 14 (8.07.13).
27 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: ALONSO BONAFONT JORGE JAVIER. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 133, S 8, H V 129552,I/A 13 (18.06.12).
10 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: BETANCORT MEDINA AMPARO MARIA. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 133, S 8, H V 129552,I/A 11 ( 1.02.11).
Nombramientos. Apoderado: HENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 133, S 8, H V 129552, I/A12 ( 1.02.11).
17 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: VENTURA PARADINAS MARIA ANGELES. Nombramientos. Apoderado: ARASSA BARATIA JOSEMARIA. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 132, S 8, H V 129552, I/A 9 ( 5.11.09).
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ CHAFER DESAMPARADOS. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 132, S 8, H V 129552, I/A10 ( 5.11.09).
25 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ ESCUDERO SILVIA. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ INFANTEFERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO. Datos registrales. T 8902, L 6188, F 132, S 8, H