Buscador CIF Logo

Actos BORME Marport Spain Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Marport Spain Sl

Actos BORME Marport Spain Sl - B85416907

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Marport Spain Sl con CIF B85416907

🔙 Perfil de Marport Spain Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Marport Spain Sl

21 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: SANTIAGO PEREZ ANTONIO;DE ALVEAR TRENOR INES;CHRISTIAN NIELSENMICHEL;POCKLINGTON VICENTE ANA;SUAREZ DE CENTI MARTINEZ LUIS;MEDRANO MARTINEZ ROBERTO;MUNTANOYAGUE CESAR. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 29, S 8, H PO 47644, I/A 12 (14.12.23).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 29, S 8, H PO 47644, I/A 13(14.12.23).

25 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: BARROS FERREIRO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 28, S 8, H PO 47644,I/A 11 (16.11.20).

13 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: PEREZ GARCIA HERMENEGILDO;PEREZ GARCIA HERMENEGILDO. Apo.Sol.: PEREZ GARCIAHERMENEGILDO. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 27, S 8, H PO 47644, I/A 9 ( 4.11.20).

26 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ GARCIA HERMENEGILDO;MATTHEW BOUCHER. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 26, S8, H PO 47644, I/A 8 (15.06.18).

21 de Junio de 2018
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10. Cambio de domicilio social. CMNO CAMIÑO DO CHOUZO 1(VIGO). Datos registrales. T 3538, L 3538, F 26, S 8, H PO 47644, I/A 7 (14.06.18).

24 de Agosto de 2016
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AIRMAR TECHNOLOGY CORPORATION. Ceses/Dimisiones.Adm. Unico: MARPORT MARINE CANADA INC. Nombramientos. Adm. Unico: AIRMAR TECHNOLOGY CORPORATION. Datosregistrales. T 3538, L 3538, F 24, S 8, H PO 47644, I/A 5 (10.08.16).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA HERMENEGILDO. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 25, S 8, H PO 47644, I/A 6(10.08.16).

28 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: MAGAN ROLDAN JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA HERMENEGILDO.Datos registrales. T 3538, L 3538, F 22, S 8, H PO 47644, I/A 4 (18.05.10).

08 de Abril de 2009
Cambio de domicilio social. C/ CHANO PIÑEIRO 3-5 (VIGO). Datos registrales. T 3538, L 3538, F 20, S 8, H PO 47644, I/A 1(25.03.09).

Nombramientos. Apoderado: MAGAN ROLDAN JUAN ANTONIO;SANTIAGO PEREZ ANTONIO;DE ALVEAR TRENORINES;CHRISTIAN NIELSEN MICHEL;POCKLINGTON VICENTE ANA;SUAREZ DE CENTI MARTINEZ LUIS;MEDRANO MARTINEZROBERTO;MUNTAN OYAGUE CESAR. Datos registrales. T 3538, L 3538, F 22, S 8, H PO 47644, I/A 3 (25.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información