Actos BORME de Martin Directorship Sl
04 de Mayo de 2023Modificaciones estatutarias. INTRODUCCION DEL ARTICULO 6 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T41823 , F 56, S 8, H M 674913, I/A 18 (25.04.23).
28 de Octubre de 2022Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GANDASOLAR 17 SL. Datos registrales. T 41823 , F 55, S 8, H M674913, I/A 17 (21.10.22).
27 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PENTREATHNICHOLAS;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;DE LA SERNA GOULD LUIS JAIME.Apo.Manc.: TIELVE MARTINEZ DEGUERE脩U BEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;MOLINARI MIRKO PIETRO EMILIO;MOLINA DEL VALLE ELENA. Apo.Sol.:
25 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CHICO GONZALEZ JAIME;FERNANDEZ DE SALAMANCA JAIME;DOMINGUEZ BAYONLORETO;SANROMA OCA DE ZAYAS I脩IGO. Datos registrales. T 41823 , F 52, S 8, H M 674913, I/A 15 (18.04.22).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 41823 , F 51, S 8, H M 674913, I/A 14(26.04.21).
29 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 37900 , F 120, S 8, H M 674913, I/A 13 (22.04.21).
21 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA;GARGOLES SAES BORJA FRANCISCO;SANROMA OCA DEZAYAS I脩IGO;BESTUE PUYUELO GEMA. Datos registrales. T 37900 , F 120, S 8, H M 674913, I/A 12 (14.04.21).
02 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO;MICO VALDENEBRO FERNANDO;DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;TIELVE MARTINEZ DE GUERE脩U BEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;RIBALLO FERNANDEZANTONIO ENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T37900 , F 116, S 8, H M 674913, I/A 7 (25.09.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA. Datos registrales. T 37900 , F 119, S 8, H M 674913, I/A 8(25.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 37900 , F 119, S 8, H M 674913, I/A 9(25.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO;PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 37900 , F 119, S 8, H M674913, I/A 10 (25.09.20).
Revocaciones. Apoderado: MICO VALDENEBRO FERNANDO. Datos registrales. T 37900 , F 119, S 8, H M 674913, I/A 11(25.09.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 37900 , F 116, S 8, H M 674913, I/A 6 (23.04.20).
27 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL N潞 1, 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 37900 , F 115, S 8, HM 674913, I/A 5 (20.04.20).
29 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 37900 , F 114, S 8, H M674913, I/A 4 (22.05.19).
23 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: X-ELIO ENERGY SL. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Cambio de domicilio social. C/OMBU 3 2陋 (MADRID). Cambio de objeto social. a) El desarrollo de zayectos de energ铆as renovables, principalmente de energ铆asolar fotovoltaica, en cualquiera e sus fases, desde fcqroinOci贸n de proyectos hasta la explotaci贸n de parques y plantas. b) Lafabricaci贸n, comercializaci贸n y venta de cualquier elemento constitutivo de instalaciones de. Datos registrales. T 37900 , F 113, S 8,H M 674913, I/A 2 (16.10.18).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: X-ELIO ENERGY SL. Datos registrales. T 37900 , F 113, S 8, H M 674913, I/A 3(16.10.18).
26 de Julio de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 4.07.18. Objeto social: a) El asesoramiento y consultor铆a en general de toda clase deempresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral, econ贸mico, multimedia, internet, servicios, en cuyo caso la sociedadactuar谩 como sociedad de medios o de intermediaci贸n. b) La actividad inmobiliaria y la urbanizaci贸n, con. Domicilio: C/ MONTEESQUINZA 30 - BAJO, IZQUIERDA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELESSL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 37900 , F 111, S 8, H M 674913, I/A 1 (19.07.18).