Buscador CIF Logo

Actos BORME Masas Congeladas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Masas Congeladas Sa

Actos BORME Masas Congeladas Sa - A33511064

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Masas Congeladas Sa con CIF A33511064

馃敊 Perfil de Masas Congeladas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Masas Congeladas Sa

30 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2198 , F 219, S 8, H AS 17093, I/A 40 (23.11.23).

27 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS NOE. Datos registrales. T 2198 , F 219, S 8, H AS 17093, I/A 39(15.03.23).

07 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SUAREZ JAVIER. Datos registrales. T 2198 , F 218, S 8, H AS 17093, I/A 38 (30.01.23).

02 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO.Consejero: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: GARCIA SUAREZ JAVIER.Con.Delegado: GARCIA SUAREZ JAVIER. Cons.Del.Sol: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Nombramientos. Adm. Unico:ALIMERKA SA. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificaci贸n de los estatutos sociales. Cambio de objeto social.C.N.A.E. n潞 107. La fabricaci贸n y venta al por mayor y al por menor de toda clase de productos de panader铆a, pasteler铆a y confiter铆a. Ala explotaci贸n directa o indirecta de toda clase de edificios y fincas en general y as铆 como la permuta, arrendamiento, cesi贸n y donaci贸nde toda clase de bienes mu. Datos registrales. T 2198 , F 203, S 8, H AS 17093, I/A 37 (22.12.22).

20 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2198 , F 202, S 8, H AS 17093, I/A 36 (13.12.22).

20 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: LLERANDI FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 2198 , F 202, S 8, H AS 17093, I/A 35 (7.04.22).

08 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2198 , F 202, S 8, H AS 17093, I/A 34 (28.10.21).

08 de Julio de 2021
Nombramientos. Cons.Del.Sol: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 2198 , F 202, S 8, H AS 17093, I/A 33(28.06.21).

22 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: MANCEBO ALVAREZ VERONICA. Datos registrales. T 2198 , F 202, S 8, H AS 17093, I/A 32(15.06.21).

21 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: LLERANDI FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 2198 , F 116, S 8, H AS 17093, I/A 31(13.04.21).

21 de Enero de 2021
Nombramientos. Apoderado: ANTU脩A ALBUERNE COVADONGA. Datos registrales. T 2198 , F 116, S 8, H AS 17093, I/A 30(12.01.21).

28 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GUERRA MARIA PILAR;FERNANDEZ GONZALEZ LAURA. Datos registrales. T 2198 , F115, S 8, H AS 17093, I/A 29 (20.08.19).

27 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO;MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS;GARCIA SUAREZJAVIER. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: GARCIASUAREZ JAVIER. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZALEJANDRO. Consejero: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: GARCIASUAREZ JAVIER. Con.Delegado: GARCIA SUAREZ JAVIER. Datos registrales. T 2198 , F 115, S 8, H AS 17093, I/A 28 (19.02.19).

29 de Octubre de 2018
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2198 , F 115, S 8, H AS 17093, I/A 27 (19.10.18).

19 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2198 , F 115, S 8, H AS 17093, I/A26 (11.01.18).

01 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2198 , F 115, S 8, H AS 17093, I/A25 (21.02.17).

15 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2198 , F 115, S 8, H AS 17093, I/A24 ( 7.01.16).

21 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO;MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS;GARCIA SUAREZJAVIER. Cons.Del.Sol: GARCIA SUAREZ JAVIER. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Secretario: MALLADAMARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO;MALLADA MARTINEZ JOSELUIS;GARCIA SUAREZ JAVIER. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO.Con.Delegado: GARCIA SUAREZ JAVIER. Datos registrales. T 2198 , F 114, S 8, H AS 17093, I/A 23 (12.03.14).

14 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2198 , F 114, S 8, H AS 17093,I/A 22 ( 7.12.12).

18 de Enero de 2012
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. LUGAR CASTIELLO 145 -LUGO DE LLANERA (LLANERA). Datos registrales. T 2198 , F 114, S 8, H AS 17093, I/A 21 ( 5.01.12).

31 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MANCEBO ALVAREZ VERONICA. Datos registrales. T 2198 , F 113, S 8, H AS 17093, I/A 20(19.10.11).

30 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN ALVAREZ JOSE MANUEL. Presidente: MARTIN ALVAREZ JOSE MANUEL.Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO. Reelecciones. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSELUIS. Datos registrales. T 2198 , F 113, S 8, H AS 17093, I/A 19 (17.06.11).

22 de Febrero de 2010
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 2潞.- El domicilio social se fija en Llanera, Castiello s/n. El 贸rganode administraci贸n podr谩 establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientosindustriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en. Cambio de domicilio social. LUGAR CASTIELLO, S/N (LLANERA).Datos registrales. T 2198 , F 113, S 8, H AS 17093, I/A 18 (10.02.10).

28 de Enero de 2010
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2198 , F 113, S 8, H AS 17093, I/A 17 (18.01.10).

05 de Junio de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: RIVERO INFIESTA MARIA DEL SOCORRO. Datos registrales. T 2198 , F 113, S 8, H AS 17093, I/A 16(26.05.09).

24 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS NOE. Secretario: RIVERO INFIESTA MARIA DEL SOCORRO.Consejero: RIVERO INFIESTA MARIA DEL SOCORRO;MARTIN ALVAREZ JOSE MANUEL. Presidente: MARTIN ALVAREZ JOSEMANUEL. Consejero: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS;GARCIA SUAREZ JAVIER. Con.Delegado: GARCIA SUAREZ JAVIER.Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRO;MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS;MARTIN ALVAREZ JOSEMANUEL;GARCIA SUAREZ JAVIER. Presidente: MARTIN ALVAREZ JOSE MANUEL. Secretario: MALLADA MARTINEZ JOSE LUIS.Cons.Del.Sol: GARCIA SUAREZ JAVIER. Datos registrales. T 2198 , F 16, S 8, H AS 17093, I/A 15 (11.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n