Buscador CIF Logo

Actos BORME Masmovil Investments Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Masmovil Investments Sl

Actos BORME Masmovil Investments Sl - B87407821

Tenemos registrados 39 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Masmovil Investments Sl con CIF B87407821

馃敊 Perfil de Masmovil Investments Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Masmovil Investments Sl

16 de Septiembre de 2020
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 35534 , F 97, S 8, H M 611860, I/A 39 ( 9.09.20).

04 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 35534 , F 97, S 8, H M 611860, I/A 38(28.01.20).

28 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: RUIZ SERRANO DANIEL. Datos registrales. T 35534 , F 97, S 8, H M 611860, I/A 37 (21.11.19).

22 de Noviembre de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: XFERA MOVILES SA. Datos registrales. T 35534 , F 94, S 8, H M611860, I/A 34 (15.11.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. Datos registrales. T 35534 , F 94, S 8, H M 611860, I/A 35(15.11.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO GOMEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 35534 , F 95, S 8, H M 611860, I/A 36 (15.11.19).

25 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MU脩OZ PABLO. Datos registrales. T 35534 , F 94, S 8, H M 611860, I/A 33 (18.09.19).

24 de Junio de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 35534 , F93, S 8, H M 611860, I/A 32 (17.06.19).

26 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 35534 , F 91, S 8, H M 611860, I/A 31(18.09.18).

31 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DUATO SALMERON EDUARDO. Datos registrales. T 35534 , F 87, S 8, H M 611860, I/A 27(24.05.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTERO SANCHEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 35534 , F 90, S 8, H M 611860, I/A28 (24.05.18).

Revocaciones. Apoderado: SODERBERG OLOF URBAN. Datos registrales. T 35534 , F 91, S 8, H M 611860, I/A 29 (24.05.18).

Revocaciones. Apoderado: MOLINA ZAMORA FERNANDO. Datos registrales. T 35534 , F 91, S 8, H M 611860, I/A 30 (24.05.18).

19 de Marzo de 2018
Modificaciones estatutarias. 5. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 35534 , F 87, S 8, H M 611860, I/A 26 ( 7.03.18).

26 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 35534 , F 87, S 8, H M 611860, I/A 25(16.02.18).

20 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR CUESTA OSCAR. Datos registrales. T 35534 , F 85, S 8, H M 611860, I/A 24 (13.02.18).

19 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO. Datos registrales. T 35534 , F 85, S 8, H M 611860, I/A 23(11.12.17).

04 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: RUIZ SERRANO DANIEL. Datos registrales. T 35534 , F 85, S 8, H M 611860, I/A 22 (24.11.17).

19 de Mayo de 2017
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA VEGA 15 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 35534 , F 85, S 8, H M 611860, I/A 21(11.05.17).

04 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: TAULET FERRANDO EDUARDO. Datos registrales. T 35534 , F 84, S 8, H M 611860, I/A 20(24.04.17).

24 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO;CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado:RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO;CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34104 , F 219, S 8, H M 611860, I/A14 (15.02.17).

Nombramientos. Apoderado: MOLINA ZAMORA FERNANDO;SANTOS FERNANDEZ MIGUEL;SODERBERG OLOF URBAN. Datosregistrales. T 34104 , F 220, S 8, H M 611860, I/A 15 (15.02.17).

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GRANADOS BELEN;DELGADO DOMINGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado:MARTINEZ MU脩OZ PABLO;LOIS CIGARRAN PEDRO;LOPEZ GRANADOS BELEN;CARDONA ARRANZ BELEN;FREIRE BARRALPABLO. Datos registrales. T 34104 , F 221, S 8, H M 611860, I/A 16 (15.02.17).

Nombramientos. Apoderado: RIVERA MATIAS MANUEL;PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 34104 , F 222, S 8, H M611860, I/A 17 (16.02.17).

Revocaciones. Apoderado: POLO ESCRI脩A FRANCISCO JAVIER;DUARTE GARCIA ROBERTO;MOLINA ZAMORA FERNANDO.Apo.Man.Soli: BLASCO MORENO JORGE;RIVERA MATIAS MANUEL;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: SUAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;DEL CORRO GARCIA LOMAS JOSE MARIA;MARIN DE LAPLAZA FRANCISCO JAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;TAULET FERRANDO EDUARDO. Datos registrales. T 34104 , F224, S 8, H M 611860, I/A 18 (16.02.17).

Nombramientos. Apoderado: LUQUE RUIZ DE MIER FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 35534 , F 83, S 8, H M 611860, I/A19 (16.02.17).

19 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: LEVENFELD BEAZCOCHEA ALBERTO. Datos registrales. T 34104 , F 217, S 8, H M 611860, I/A 12 (9.09.16).

Revocaciones. Apoderado: RIVERA MATIAS MANUEL;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Apo.Man.Soli: RIVERA MATIAS MANUEL;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34104 , F 217, S 8, H M611860, I/A 13 ( 9.09.16).

29 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ GARCIA ANGEL-MARIA. Datos registrales. T 34104 , F 217, S 8, H M 611860, I/A 11(18.03.16).

29 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO MORENO JORGE. Datos registrales. T 34104 , F 215, S 8, H M 611860, I/A 10(19.02.16).

10 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 33999 , F 161, S 8, H M 611860, I/A 7 (2.02.16).

Nombramientos. Apoderado: DELGADO DOMINGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 33999 , F 162, S 8, H M 611860, I/A 8 (2.02.16).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GRANADOS BELEN. Datos registrales. T 33999 , F 162, S 8, H M 611860, I/A 9 ( 2.02.16).

27 de Enero de 2016
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO. Datos registrales. T 33999 , F 161, S 8, H M 611860, I/A 6(19.01.16).

19 de Noviembre de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.10.15. Objeto social: a) La prestaci贸n de servicios de telecomunicaciones mediante laexplotaci贸n de redes o la reventa del servicio telef贸nico, telefon铆a m贸vil, fija, de transmisi贸n de datos, internet y televisi贸n, y eldesarrollo de aplicaciones inform谩ticas. b) La prestaci贸n y comercializaci贸n de servicios a trav茅s... Domicilio: VIA DE LAS DOSCASTILLAS Km 33 - COMPLEJO ATICA, E (POZUELO DE ALARCON). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: MASMOVIL BROADBAND SL. Nombramientos. Representan: SPENGER MEINRAD. Adm. Unico: MASMOVILIBERCOM SA. Datos registrales. T 33999 , F 155, S 8, H M 611860, I/A 1 (10.11.15).

Nombramientos. Apoderado: RIVERA MATIAS MANUEL;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER;POLO ESCRI脩A FRANCISCOJAVIER;DUARTE GARCIA ROBERTO;MOLINA ZAMORA FERNANDO. Datos registrales. T 33999 , F 158, S 8, H M 611860, I/A 2(10.11.15).

Nombramientos. Apoderado: LEVENFELD BEAZCOCHEA ALBERTO. Datos registrales. T 33999 , F 160, S 8, H M 611860, I/A 3(10.11.15).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GARCIA ANGEL-MARIA. Datos registrales. T 33999 , F 160, S 8, H M 611860, I/A 4(10.11.15).

Nombramientos. Apoderado: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO;GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 33999, F 160, S 8, H M 611860, I/A 5 (10.11.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n