Actos BORME de Mateo Inurria 30 Sl
03 de Agosto de 2023Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA TERESA. Datos registrales. T 30477 , F 52, S 8, H M 201309, I/A 39 (26.07.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA TERESA. Datos registrales. T 30477 , F 52, S 8, H M 201309, I/A 40(26.07.23).
28 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT ENRIQUE.Datos registrales. T 30477 , F 51, S 8, H M 201309, I/A 38 (21.03.23).
06 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO HERRERA MARIA. Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO HERRERA MARIA. Apo.Man.Soli:ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 30477 , F 51, S 8, H M 201309, I/A 37 (29.09.22).
17 de Mayo de 2021Nombramientos. Vicepresid.: ALONSO DE DIEGO MARIA. Vicesecret.: GAITE ALONSO MYRIAM. Datos registrales. T 30477 , F51, S 8, H M 201309, I/A 36 (10.05.21).
18 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Presidente: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Nombramientos. Presidente: ALONSO JENTOFT CARLOS. Datos registrales. T30477 , F 50, S 8, H M 201309, I/A 35 (11.12.20).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: GAITE ALONSO MIRIAM. Datos registrales. T 30477 , F 48, S 8, H M 201309, I/A 34 (30.11.20).
18 de Junio de 2020Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO MYRIAM. Datos registrales. T 30477 , F 48, S 8, H M 201309, I/A 33 (11.06.20).
27 de Septiembre de 2019Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA ENRIQUE. Datos registrales. T 30477 , F 48, S 8, H M 201309, I/A 32 (19.09.19).
26 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS.Datos registrales. T 30477 , F 48, S 8, H M 201309, I/A 31 (19.02.19).
31 de Octubre de 2018Nombramientos. Consejero: VARELA ALONSO JAVIER. Datos registrales. T 30477 , F 47, S 8, H M 201309, I/A 30 (22.10.18).
30 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN HINOJAR SANDRA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VARELA ALONSO JAVIER. Datosregistrales. T 30477 , F 45, S 8, H M 201309, I/A 29 (22.10.18).
11 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: GAITE ALONSO EDUARDO. Nombramientos. Secretario: ALIQUE ALONSO CRISTINA. Datosregistrales. T 30477 , F 44, S 8, H M 201309, I/A 27 ( 3.08.17).
Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO JAVIER;ALONSO PEDREGAL IGNACIO;ALIQUE ALONSO CRISTINA. Datosregistrales. T 30477 , F 45, S 8, H M 201309, I/A 28 ( 3.08.17).
18 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: GAITE ALONSO JAVIER;ALIQUE ALONSO CRISTINA. Apoderado: GAITE ALONSO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: ALIQUE ALONSO CRISTINA;ALONSO PEDREGAL IGNACIO;GAITE ALONSO JAVIER. Datosregistrales. T 30477 , F 42, S 8, H M 201309, I/A 26 ( 8.05.17).
11 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO AVENTIN ANTONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO AVENTIN ANTONIO.Datos registrales. T 30477 , F 42, S 8, H M 201309, I/A 24 ( 2.08.16).
Nombramientos. Consejero: ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 30477 , F 42, S 8, H M 201309, I/A 25 ( 4.08.16).
26 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO HERRERA MARIA. Apo.Man.Soli: ALONSO HERRERA MARIA. Datos registrales. T 30477 , F40, S 8, H M 201309, I/A 23 (18.05.16).
04 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: GAITE ALONSO JAVIER. Datos registrales. T 30477 , F 39, S 8, H M 201309, I/A 22 (26.01.16).
01 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Revocaciones. Apo.Sol.: VALERO GUTIERREZ DEL OLMOPABLO. Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales. T 30477 , F 38, S 8, H M 201309, I/A 20 (24.03.15).
Ceses/Dimisiones. Secretario: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Presidente: ALONSO JENTOFT JOSE LUIS. Nombramientos.Presidente: ALONSO JENTOFT ALBERTO. Secretario: GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 30477 , F 39, S 8, H M201309, I/A 21 (24.03.15).
13 de Marzo de 2014Nombramientos. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales. T 30477 , F 38, S 8, H M 201309, I/A 19 ( 5.03.14).
06 de Noviembre de 2013Modificaciones estatutarias. 13. Soberanía de la Junta General Convocatoria.-. Datos registrales. T 30477 , F 38, S 8, H M201309, I/A 18 (29.10.13).
13 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: LAMIGUEIRO PEREA MIGUEL. Apo.Sol.: MORENCOS RUIZ JARABO PILAR. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ;ALIQUE ALONSO CRISTINA. Datos registrales. T 21366 , F 78, S 8, H M 201309, I/A17 ( 5.02.13).
31 de Agosto de 2011Nombramientos. Consejero: GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 21366 , F 78, S 8, H M 201309, I/A 16 (17.08.11).
22 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO AVENTIN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 21366 , F 76, S 8, H M 201309, I/A 12(12.07.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO AVENTIN MIGUEL ANGEL. Apoderado: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Datos registrales.T 21366 , F 76, S 8, H M 201309, I/A 13 (12.07.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO DE DIEGO MARIA;GAITE ALONSO EDUARDO. Datos registrales. T 21366 , F 76, S 8, HM 201309, I/A 14 (12.07.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALERO GUTIERREZ DEL OLMO PABLO;MORENCOS RUIZ JARABO PILAR;MARTIN HINOJARSANDRA Datos registrales. T 21366 , F 77, S 8, H M 201309, I/A 15 (12.07.11).
17 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO DE DIEGO BEATRIZ. Nombramientos. Consejero: ALONSO DE DIEGO MARIA. Datosregistrales. T 21366 , F 75, S 8, H M 201309, I/A 11 ( 5.08.10).