Buscador CIF Logo

Actos BORME Maxam Mobile Solutions Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Maxam Mobile Solutions Sl

Actos BORME Maxam Mobile Solutions Sl - B87499596

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Maxam Mobile Solutions Sl con CIF B87499596

馃敊 Perfil de Maxam Mobile Solutions Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Maxam Mobile Solutions Sl

07 de Mayo de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 38987 , F 207, S 8, H M 618990, I/A 14 (29.04.21).

21 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMINO DE MIGUEL MIGUEL. Secretario: GASTA脩ADUY TILVE CARLOS MANUEL.Nombramientos. Consejero: GASTA脩ADUY TILVE CARLOS MANUEL. Secretario: GASTA脩ADUY TILVE CARLOS MANUEL.Datos registrales. T 38987 , F 206, S 8, H M 618990, I/A 13 (14.04.21).

30 de Marzo de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MAXAMCORP INTERNATIONAL SL. Datos registrales. T 38987 , F 206, S 8, H M618990, I/A 12 (23.03.21).

24 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARDAMA GOMEZ FERNANDA;DE LA CALLE VERGARA MARIA DE LAS MARISMAS. Datosregistrales. T 38987 , F 206, S 8, H M 618990, I/A 11 (17.07.20).

15 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMINO DE MIGUEL MIGUEL. Apo.Man.Soli: GARCIA LUJAN JUAN CARLOS;PRESMANESMARTINEZ I脩IGO FEDERICO. Datos registrales. T 38987 , F 201, S 8, H M 618990, I/A 10 ( 8.06.20).

04 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: FLOREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL;MONTORO LOPEZ JUAN JOSE. Nombramientos.Consejero: GARCIA LUJAN JUAN CARLOS. Presidente: GARCIA LUJAN JUAN CARLOS. Consejero: CAMINO DE MIGUELMIGUEL;PRESMANES MARTINEZ I脩IGO FEDERICO. Datos registrales. T 38987 , F 201, S 8, H M 618990, I/A 9 (27.05.20).

27 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARAMIO RUIZ RAMON. Presidente: PARAMIO RUIZ RAMON. Revocaciones. Apoderado:PARAMIO RUIZ RAMON. Datos registrales. T 38987 , F 201, S 8, H M 618990, I/A 8 (20.02.20).

04 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA SA脩UDO DIEZ FELIPE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: PARAMIO RUIZ RAMON.

29 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA-SA脩UDO DIEZ FELIPE MANUEL. Presidente: GARCIA-SA脩UDO DIEZ FELIPE MANUEL.Nombramientos. Consejero: PARAMIO RUIZ RAMON. Presidente: PARAMIO RUIZ RAMON. Datos registrales. T 34411 , F 132, S8, H M 618990, I/A 6 (22.07.19).

19 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: OSTAREK RALPH HEINRICH;MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34411 , F132, S 8, H M 618990, I/A 5 (11.09.17).

14 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSTAREK RALPH HEINRICH;MELLADO ARTECHE JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero:FLOREZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL;MONTORO LOPEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 34411 , F 132, S 8, H M 618990, I/A 4 (2.03.17).

16 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SA脩UDO DIEZ FELIPE MANUEL;OSTAREK RALPH HEINRICH;MELLADO ARTECHEJOSE MANUEL;CAMINO DE MIGUEL MIGUEL;CARDAMA GOMEZ FERNANDA;GASTA脩ADUY TILVE CARLOS MANUEL;DETERESA PERTUSA MARTA. Datos registrales. T 34411 , F 127, S 8, H M 618990, I/A 2 ( 9.03.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA CALLE VERGARA MARIA DE LAS MARISMAS. Datos registrales. T 34411 , F 130, S 8, HM 618990, I/A 3 ( 9.03.16).

08 de Marzo de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.02.16. Objeto social: La investigaci贸n, dise帽o, desarrollo, fabricaci贸n, comercializaci贸n yexplotaci贸n por cualquier medio admitido en Derecho de maquinaria de almacenamiento, transporte, carga, bombeo, activaci贸n,

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n