Buscador CIF Logo

Actos BORME Maxlan Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Maxlan Sociedad Anonima

Actos BORME Maxlan Sociedad Anonima - A80183288

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Maxlan Sociedad Anonima con CIF A80183288

馃敊 Perfil de Maxlan Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Maxlan Sociedad Anonima

10 de Noviembre de 2023
Nombramientos. VsecrNoConsj: GOMEZ ROLDOS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 38678 , F 83, S 8, H M 51605, I/A 60 (2.11.23).

30 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL;DE MANUEL NARVAEZ ALVARO;ALONSO MARBANVANESSA;GOMEZ ROLDOS MARIA ISABEL;GOMEZ REQUESENS PEDRO LUIS;VILLANUEVA HIDALGO JESUSJAVIER;SANCHEZ CUMBAL ADRIANA DANIELA;CASTELLANOS ORTEGA ELENA;HORMIGOS JIMENEZ ELENA;MOZOTAVILLALBA MARIA DEL CARMEN;SERRA GONZALEZ ENRIQUE;FERNANDEZ VEGA NATALIA;EGEA ALONSO ALVARO;MUELARODRIGUEZ EDUARDO;ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL;CUELLAR SANCHEZ SARA;GOMEZ DOBLAS INMACULADA;OCA脩AGONZALEZ AMPARO;ULLOA PADILLA JAIME. Datos registrales. T 38678 , F 81, S 8, H M 51605, I/A 59 (23.10.23).

10 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: HUERRES FANJUL ALEJANDRO. Datos registrales. T 38678 , F 81, S 8, H M 51605, I/A 57 (3.08.23).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA PEREZ PATRICIA;GARCIA PEREZ PATRICIA. Datos registrales. T 38678 , F 81, S 8, H M51605, I/A 58 ( 3.08.23).

27 de Julio de 2023
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARCIA PEREZ PATRICIA. Datos registrales. T 38678 , F 80, S 8, H M 51605, I/A 56(20.07.23).

12 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: DE LAS HERAS GARCIA GRANELLI JOSE LUIS;POZO LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 38678, F 80, S 8, H M 51605, I/A 55 ( 5.05.23).

11 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: AMOR ALAMEDA ALFONSO. Datos registrales. T 38678 , F 80, S 8, H M 51605, I/A 54 ( 4.05.23).

27 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ VEGA NATALIA;EGEA ALONSO ALVARO;MUELA RODRIGUEZEDUARDO;ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL;CUELLAR SANCHEZ SARA;GOMEZ DOBLAS INMACULADA;OCA脩A GONZALEZAMPARO;ULLOA PADILLA JAIME. Datos registrales. T 38678 , F 78, S 8, H M 51605, I/A 53 (17.03.23).

12 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTIN ROBLES VICTOR. Datos registrales. T 38678 , F 78, S 8, H M 51605, I/A 52 ( 4.01.23).

12 de Julio de 2022
Reelecciones. Consejero: JODAR CASANOVA MANUEL. Datos registrales. T 38678 , F 77, S 8, H M 51605, I/A 50 ( 5.07.22).

Reelecciones. Auditor: EUDITA AH AUDITORES 1986 SAP. Datos registrales. T 38678 , F 78, S 8, H M 51605, I/A 51 ( 5.07.22).

03 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: CASTELLANOS ORTEGA ELENA;GARCIA PEREZ PATRICIA;VILLANUEVA HIDALGO JESUSJAVIER. Datos registrales. T 38678 , F 77, S 8, H M 51605, I/A 49 (27.05.22).

18 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ VEGA NATALIA. Datos registrales. T 38678 , F 76, S 8, H M 51605, I/A 47 (11.03.22).

Revocaciones. Apoderado: JAEN FRANCO ANTONIO. Datos registrales. T 38678 , F 77, S 8, H M 51605, I/A 48 (11.03.22).

24 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: MUNUERA CEBRIAN JOSEFINA;CARPINTERO GOMEZ JORGE. Datos registrales. T 38678 , F 76, S8, H M 51605, I/A 46 (17.09.21).

24 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARPINTERO GOMEZ JORGE. VsecrNoConsj: VALERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. SecreNoConsj: VALERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN. VsecrNoConsj: GARCIA PEREZ PATRICIA.Reelecciones. Consejero: SERRA GONZALEZ ENRIQUE;VELASCO ARRANZ MATEO. Presidente: VELASCO ARRANZ MATEO.Datos registrales. T 38678 , F 75, S 8, H M 51605, I/A 45 (17.08.21).

26 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: JAEN FRANCO ANTONIO. Datos registrales. T 38678 , F 74, S 8, H M 51605, I/A 42 (18.03.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Apoderado: SOLANA FERRERO ALFREDO;PERONA VILLEGASJOSE JESUS;ARRIBAS GARCIA MERCEDES;GIL MONTORO MARIA ANTONIA. Apo.Sol.: SOLANA FERRERO ALFREDO.Apoderado: SOLANA FERRERO ALFREDO;DIAZ-CRESPO BUENDIA RAMON JESUS. Datos registrales. T 38678 , F 74, S 8, H M51605, I/A 43 (18.03.21).

Revocaciones. Apoderado: SEOANE SANCHEZ GABRIEL ANGEL;SEOANE SANCHEZ GABRIEL ANGEL;JARA I脩IGO ISABEL;GILMONTORO MARIA ANTONIA;ALCITURRI ALVAREZ IGNACIO. Datos registrales. T 38678 , F 75, S 8, H M 51605, I/A 44 (18.03.21).

23 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MUNUERA CEBRIAN JOSEFINA. VsecrNoConsj: GIL MONTORO MARIA ANTONIA.SecreNoConsj: GIL MONTORO MARIA ANTONIA. Nombramientos. SecreNoConsj: GIL MONTORO MARIAANTONIA;CARPINTERO GOMEZ JORGE. VsecrNoConsj: VALERA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 38678 , F73, S 8, H M 51605, I/A 41 (16.02.21).

14 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTA CUADRENCH ALFONSO. Nombramientos. Consejero: JODAR CASANOVA MANUEL.Datos registrales. T 38678 , F 73, S 8, H M 51605, I/A 40 ( 7.08.19).

07 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: EUDITA AH AUDITORES 1986 SAP. Datos registrales. T 38678 , F 72, S 8, H M 51605, I/A 39 (31.07.19).

01 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: SERRA GONZALEZ ENRIQUE;DE LAS HERAS GARCIA GRANELLI JOSE LUIS;POZO LOZANOMANUEL;MUNUERA CEBRIAN JOSEFINA;SEOANE SANCHEZ GABRIEL ANGEL;MARTIN ROBLES VICTOR;AMOR ALAMEDAALFONSO;JARA I脩IGO ISABEL;GIL MONTORO MARIA ANTONIA;SOLANA FERRERO ALFREDO;CARPINTERO GOMEZJORGE;ALCITURRI ALVAREZ IGNACIO;GARCIA PEREZ PATRICIA;VILLANUEVA HIDALGO JESUS JAVIER;DIAZ-CRESPOBUENDIA RAMON JESUS;MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 26691 , F 225, S 8, H M 51605, I/A 38 (25.03.19).

28 de Marzo de 2019
Cambio de objeto social. La adquisici贸n de valores mobiliarios de todo tipo, ya sea en subastas judiciales promovidas como actor porBanco Caminos SA o Bancofar SA o adquiridos directamente o acreditados de Banco Caminos SA o Bancofar SA, etc. Datosregistrales. T 26691 , F 224, S 8, H M 51605, I/A 37 (21.03.19).

19 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Nombramientos. SecreNoConsj: MUNUERA CEBRIANJOSEFINA. VsecrNoConsj: GIL MONTORO MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 26691 , F 224, S 8, H M 51605, I/A 36 (12.02.19).

11 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: O脩ORO PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: COSTA CUADRENCH ALFONSO.Datos registrales. T 26691 , F 224, S 8, H M 51605, I/A 35 ( 4.09.18).

25 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: O脩ORO PEREZ JOSE MANUEL. Consejero: GIL FERNANDEZ FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: VELASCO ARRANZ MATEO. Presidente: VELASCO ARRANZ MATEO. Reelecciones. Consejero: SERRA GONZALEZENRIQUE. Datos registrales. T 26691 , F 223, S 8, H M 51605, I/A 34 (16.05.18).

25 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: SEOANE SANCHEZ GABRIEL ANGEL. Datos registrales. T 26691 , F 223, S 8, H M 51605, I/A 33(18.01.18).

24 de Enero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERAL SANCHEZ RICARDO;GOMEZ REQUESENS PEDRO LUIS;SOLANA FERRERO ALFREDO.Datos registrales. T 26691 , F 223, S 8, H M 51605, I/A 32 (17.01.18).

06 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BANCO CAMINOS SA. Presidente: BANCO CAMINOS SA. Vicepresid.: SANCHEZ BLANCOVICTOR. Consejero: SANCHEZ BLANCO VICTOR. Representan: CANADELL FERNANDEZ JUAN LUIS. Nombramientos.Consejero: O脩ORO PEREZ JOSE MANUEL. Presidente: O脩ORO PEREZ JOSE MANUEL. Consejero: GIL FERNANDEZFRANCISCO. Reelecciones. SecreNoConsj: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. T 26691 , F 222, S 8, H M 51605,I/A 31 (27.10.17).

10 de Abril de 2017
Ampliacion del objeto social. La adquisici贸n de todo tipo de bienes inmuebles, incluidos los de subastas judiciales promovidascomo actor por Banco Caminos S.A. o Bancofar S.A. o adquiridos directamente a acreditados de Banco Caminos S.A. o Bancofar S.A.,............. Datos registrales. T 26691 , F 222, S 8, H M 51605, I/A 30 (31.03.17).

03 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: EUDITA AH AUDITORES 1986 SAP. Datos registrales. T 26691 , F 221, S 8, H M 51605, I/A 29 (26.07.16).

15 de Marzo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.001.940,00 Euros. Desembolsado: 6.001.940,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.225.940,00 Euros.Resultante Desembolsado: 13.225.940,00 Euros. Datos registrales. T 26691 , F 221, S 8, H M 51605, I/A 28 ( 8.03.16).

13 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUEL SANCHEZ JUAN. Nombramientos. Consejero: SERRA GONZALEZ ENRIQUE.Reelecciones. Vicepresid.: SANCHEZ BLANCO VICTOR. Consejero: SANCHEZ BLANCO VICTOR. Datos registrales. T 26691 , F221, S 8, H M 51605, I/A 27 ( 3.07.15).

06 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: MANUEL SANCHEZ JUAN. Nombramientos. Apoderado: ROMERAL SANCHEZ RICARDO;GOMEZREQUESENS PEDRO LUIS;SOLANA FERRERO ALFREDO;PERONA VILLEGAS JOSE JESUS;ARRIBAS GARCIA MERCEDES;GILMONTORO MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 26691 , F 219, S 8, H M 51605, I/A 26 (25.03.15).

06 de Agosto de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.954.851,56 Euros. Desembolsado: 5.954.851,56 Euros. Resultante Suscrito: 7.224.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 7.224.000,00 Euros. Datos registrales. T 26691 , F 219, S 8, H M 51605, I/A 25 (29.07.14).

30 de Julio de 2014
Reelecciones. Consejero: MANUEL SANCHEZ JUAN. SecreNoConsj: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. T 26691, F 218, S 8, H M 51605, I/A 24 (22.07.14).

16 de Octubre de 2013
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 20潞 Y 21潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T26691 , F 218, S 8, H M 51605, I/A 23 ( 8.10.13).

21 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: EUDITA AH AUDITORES 1986 SAP. Datos registrales. T 26691 , F 218, S 8, H M 51605, I/A 22 (12.08.13).

26 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 767.682,44 Euros. Desembolsado: 767.682,44 Euros. Resultante Suscrito: 1.269.148,44 Euros.Resultante Desembolsado: 1.269.148,44 Euros. Datos registrales. T 26691 , F 215, S 8, H M 51605, I/A 21 (18.04.13).

04 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PI脩ERO MOYA ROQUE. Representan: SANCHEZ BLANCO VICTOR. Nombramientos. Consejero:SANCHEZ BLANCO VICTOR. Representan: CANADELL FERNANDEZ JUAN LUIS. Vicepresid.: SANCHEZ BLANCO VICTOR.Reelecciones. Consejero: BANCO CAMINOS SA. Presidente: BANCO CAMINOS SA. Datos registrales. T 26691 , F 215, S 8, H M51605, I/A 20 (25.06.12).

26 de Octubre de 2011
Nombramientos. Consejero: PI脩ERO MOYA ROQUE. Reelecciones. SecreNoConsj: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Consejero:MANUEL SANCHEZ JUAN. Datos registrales. T 3014 , F 149, S 8, H M 51605, I/A 19 (14.10.11).

30 de Marzo de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CORPORACION BANCO CAMINOS SL. Datos registrales. T 3014 , F 149, S 8, HM 51605, I/A 18 (21.03.11).

29 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Auditor: AH AUDITORES 1986 SA. Datos registrales. T 3014 , F 149, S 8, H M 51605, I/A 17 (17.09.10).

24 de Marzo de 2010
Ampliacion del objeto social. LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, YA SEA EN SUBASTAS JUDICIALES PROMOVIDASCOMO ACTOR POR BANCO CAMINOS SA O ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE A ACREDITADOS DE BANCO CAMINOS SA,...Datos registrales. T 3014 , F 148, S 8, H M 51605, I/A 16 (12.03.10).

04 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLE PARELLADA CLEMENTE. Apo.Manc.: SANCHEZ BLANCO VICTOR;MANUEL SANCHEZJUAN;CALDES LLOPIS MIGUEL. Apo.Man.Soli: ARRIBAS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. T 3014 , F 147, S 8, H M 51605,I/A 15 (25.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n