Buscador CIF Logo

Actos BORME Mazars Auditores Slp

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mazars Auditores Slp

Actos BORME Mazars Auditores Slp - B61622262

Tenemos registrados 91 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Mazars Auditores Slp con CIF B61622262

馃敊 Perfil de Mazars Auditores Slp
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Mazars Auditores Slp

29 de Diciembre de 2023
Otros conceptos: SEPARACION DEL SOCIO PROFESIONAL ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ Y CAMBIOS EN LATITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 48578 , F 95, S 8, H B 180111, I/A 131 (21.12.23).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 89.616,39 Euros. Resultante Suscrito: 940.993,06 Euros. Datos registrales. T 48578 , F95, S 8, H B 180111, I/A 132 (21.12.23).

27 de Diciembre de 2023
Revocaciones. APODERADO: SANCHEZ RODRIGUEZ ENRIQUE. APOD.SOL/MAN: SANCHEZ RODRIGUEZ ENRIQUE. Datosregistrales. T 48578 , F 93, S 8, H B 180111, I/A 128 (15.12.23).

Nombramientos. APODERAD.SOL: ALONSO SAN MILLAN MARTA. Datos registrales. T 48578 , F 93, S 8, H B 180111, I/A 129(15.12.23).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GRANDE PEREZ MARIA. Datos registrales. T 48578 , F 94, S 8, H B 180111, I/A 130(15.12.23).

10 de Marzo de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 48578 , F 92, S 8, H B 180111, I/A 126( 2.03.23).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 48578 , F 93, S 8, H B 180111, I/A127 ( 2.03.23).

21 de Febrero de 2023
Ampliaci贸n de capital. Capital: 46.632,15 Euros. Resultante Suscrito: 1.030.609,45 Euros. Datos registrales. T 48578 , F 91, S 8, HB 180111, I/A 125 (13.02.23).

16 de Enero de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: PABLO MAYORAL MANUEL. Datos registrales. T 48165 , F 183, S 8, H B 180111, I/A 123 (5.01.23).

Nombramientos. APODERAD.SOL: VACA DE OSMA ULACIA MANUEL RAMON. Datos registrales. T 48578 , F 91, S 8, H B180111, I/A 124 ( 5.01.23).

23 de Noviembre de 2022
Nombramientos. APODERAD.SOL: GREGORIO PUEBLA MARIA. Datos registrales. T 48165 , F 179, S 8, H B 180111, I/A 119(16.11.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CEREIGIDO GONZALEZ RAUL. Datos registrales. T 48165 , F 180, S 8, H B 180111, I/A 120(16.11.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: VALERIO SARDON PABLO. Datos registrales. T 48165 , F 181, S 8, H B 180111, I/A 121(16.11.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: NIETO GALLEGO DIEGO. Datos registrales. T 48165 , F 182, S 8, H B 180111, I/A 122(16.11.22).

11 de Marzo de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 102.752,46 Euros. Resultante Suscrito: 983.977,30 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 5: RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES. Otros conceptos: INCORPORACION DE DOS NUEVOS SOCIOSPROFESIONALES: DON BREOGAN PORTA MACIA Y DON XOAN JOVANNI GUIRAL. Datos registrales. T 46557 , F 138, S 8, H B180111, I/A 118 ( 3.03.22).

27 de Enero de 2022
Nombramientos. APODERAD.SOL: PORTA MACIA BREOGAN. Datos registrales. T 46557 , F 137, S 8, H B 180111, I/A 116(19.01.22).

Nombramientos. APODERAD.SOL: NAVARRETE ESPU脩A MIGUEL. Datos registrales. T 46557 , F 138, S 8, H B 180111, I/A 117(19.01.22).

28 de Diciembre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 46557 , F 137, S 8, H B 180111, I/A114 (20.12.21).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 46557 , F 137, S 8, H B 180111, I/A115 (20.12.21).

08 de Octubre de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.488,16 Euros. Resultante Suscrito: 795.160,52 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:86.064,32 Euros. Resultante Suscrito: 881.224,84 Euros. Otros conceptos: RENUMERACION DE PARTICIPACIONES YCONSIGUIENTE CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS. Cambio de objeto social. AMPLIAR EN: "ASIMISMO, LASOCIEDAD PODRA REALIZAR FORMACION RELACIONADA CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES QUE DESARROLLE.".Datos registrales. T 46557 , F 136, S 8, H B 180111, I/A 113 ( 1.10.21).

05 de Octubre de 2021
Otros conceptos: SEPARACION DE JOSEP POU SETO COMO SOCIO PROFESIONAL Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LASPARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 46557 , F 136, S 8, H B 180111, I/A 112 (22.09.21).

18 de Agosto de 2021
Otros conceptos: CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 46524 , F 130, S8, H B 180111, I/A 111 (10.08.21).

29 de Abril de 2021
Revocaciones. APODERADO: TUSET JUBERA FRANCISCO;TUSET JUBERA FRANCISCO. APODERAD.SOL: TUSET JUBERAFRANCISCO. Datos registrales. T 46524 , F 129, S 8, H B 180111, I/A 108 (21.04.21).

Revocaciones. CONSEJERO: BUENO BUENO JOSE LUIS. PRESIDENTE: BUENO BUENO JOSE LUIS. CONS.DEL.MAN: BUENOBUENO JOSE LUIS. SECRETARIO: CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR. Nombramientos. CONSEJERO: MARCOS CORRALCARLOS. SECRETARIO: MARCOS CORRAL CARLOS. PRESIDENTE: CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR. CONS.DEL.MAN:MARCOS CORRAL CARLOS. Datos registrales. T 46524 , F 130, S 8, H B 180111, I/A 109 (21.04.21).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR;MARCOS CORRAL CARLOS. Datos registrales. T46524 , F 130, S 8, H B 180111, I/A 110 (21.04.21).

07 de Mayo de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 55.359,58 Euros. Resultante Suscrito: 804.648,68 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO5: RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSIGUIENTE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS MISMAS.Otros conceptos: INCORPORACION DE UN NUEVO SOCIO PROFESIONAL: DON OSCAR HERRANZ LOPEZ. Datos registrales.T 46524 , F 129, S 8, H B 180111, I/A 107 (24.04.20).

17 de Abril de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: BERRAL VICENTE JUAN;PALOMINO SILVA CARLOS;CERVERA FLORES MARIA ELENA.Datos registrales. T 46524 , F 128, S 8, H B 180111, I/A 106 (31.03.20).

25 de Febrero de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 82.602,10 Euros. Resultante Suscrito: 749.289,10 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 5.-RENUMERACION DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSIGUIENTE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LASMISMAS. Datos registrales. T 46524 , F 128, S 8, H B 180111, I/A 105 (17.02.20).

28 de Noviembre de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: PALOMINO SILVA CARLOS. Datos registrales. T 46524 , F 126, S 8, H B 180111, I/A 102(21.11.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: BERRAL VICENTE JUAN. Datos registrales. T 46524 , F 126, S 8, H B 180111, I/A 103(21.11.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: CERVERA FLORES MARIA ELENA. Datos registrales. T 46524 , F 127, S 8, H B 180111, I/A104 (21.11.19).

26 de Noviembre de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.526,26 Euros. Resultante Suscrito: 831.891,20 Euros. Otros conceptos: RENUMERACION DELAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y CAMBIOS DE TITULARIDAD. INCORPORACION DEL NUEVO SOCIO PROFESIONAL, DONJUAN RIBO CAPELLADES. Datos registrales. T 46524 , F 125, S 8, H B 180111, I/A 100 (19.11.19).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 6: COMPOSICION. Cambio de objeto social. LA PRESTACION DE SERVICIOS DEAUDITORIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y DE ECONOMISTA. EL OBJETO SOCIAL PODRA DESARROLLARSE MEDIANTESU PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES PROFESIONALES CON EL MISMO OBJETO SOCIAL. Datos registrales. T 46524 ,F 126, S 8, H B 180111, I/A 101 (19.11.19).

09 de Septiembre de 2019
Revocaciones. APODERAD.SOL: DABAN FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 46524 , F 125, S 8, H B 180111, I/A 99(30.08.19).

25 de Marzo de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 46524 , F 124, S 8, H B 180111, I/A 97(14.03.19).

Nombramientos. AUDT.CTS.CON: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 46524 , F 125, S 8, H B 180111, I/A98 (14.03.19).

13 de Marzo de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: JOVANI GUIRAL XOAN. Datos registrales. T 46524 , F 123, S 8, H B 180111, I/A 93 ( 6.03.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ MIRO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 46524 , F 123, S 8, H B 180111, I/A 94( 6.03.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: TUSET JUBERA FRANCISCO. Datos registrales. T 46524 , F 124, S 8, H B 180111, I/A 95 (6.03.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PASTOR PINEDO I脩IGO. Datos registrales. T 46524 , F 124, S 8, H B 180111, I/A 96 (6.03.19).

28 de Febrero de 2019
Revocaciones. CONSEJERO: POU SETO JOSEP. SECRETARIO: POU SETO JOSEP. CONS.DEL.MAN: POU SETO JOSEP.Nombramientos. SECRETARIO: CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 85.267,65Euros. Resultante Suscrito: 761.364,94 Euros. Modificaciones estatutarias. ART.16: ORGANO DE ADMINISTRACION. Otrosconceptos: BAJA DE SOCIO PROFESIONAL: FRANCISCO TUSET JUBERA. RENUMERACION DE PARTICIPACIONES YCONSIGUIENTES CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS. Datos registrales. T 46524 , F 121, S 8, H B 180111, I/A 92(20.02.19).

22 de Agosto de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: PORTA MACIA BREOGAN. Datos registrales. T 45350 , F 130, S 8, H B 180111, I/A 90(13.08.18).

Nombramientos. APODERAD.SOL: ALONSO PARDO MARIA BELEN. Datos registrales. T 46524 , F 121, S 8, H B 180111, I/A 91(13.08.18).

26 de Julio de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: PORTA MACIA BREOGAN. Datos registrales. T 45350 , F 130, S 8, H B 180111, I/A 89(18.07.18).

10 de Abril de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 69.759,54 Euros. Resultante Suscrito: 846.632,59 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO7: PRESTACIONES ACCESORIAS Y EXCLUSIVIDAD. Otros conceptos: RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONESSOCIALES Y CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS MISMAS. Datos registrales. T 45350 , F 129, S 8, H B 180111, I/A 88 ( 3.04.18).

04 de Diciembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 45350 , F 129, S 8, H B 180111, I/A 87(24.11.17).

07 de Julio de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.952,36 Euros. Resultante Suscrito: 776.873,05 Euros. Datos registrales. T 45350 , F 129, S 8, HB 180111, I/A 86 ( 3.07.17).

07 de Junio de 2017
Revocaciones. CONS.DEL.MAN: BUENO BUENO JOSE LUIS;POU SETO JOSEP. Nombramientos. CONSEJERO:CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR. CONS.DEL.MAN: CABODEVILLA ARTIEDA MARIA PILAR;BUENO BUENO JOSELUIS;POU SETO JOSEP. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.ESTRUCTURA Y REGULACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 45350 , F 128, S 8, H B 180111, I/A 85(30.05.17).

18 de Enero de 2017
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14.- CUOTA DE LIQUIDACION. Datos registrales. T 45350 , F 127, S 8, H B 180111, I/A84 (10.01.17).

11 de Enero de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 45350 , F 127, S 8, H B 180111, I/A 83(30.12.16).

05 de Agosto de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 72.778,50 Euros. Resultante Suscrito: 757.920,69 Euros. Datos registrales. T 45350 , F 126, S 8, HB 180111, I/A 82 (27.07.16).

20 de Junio de 2016
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: POU SETO JOSEP;BUENO BUENO JOSE LUIS. Nombramientos. CONSEJERO: BUENOBUENO JOSE LUIS. PRESIDENTE: BUENO BUENO JOSE LUIS. CONSEJERO: POU SETO JOSEP. SECRETARIO: POU SETOJOSEP. CONSEJERO: BOVER HIDIROGLU ANTONI. CONS.DEL.MAN: BUENO BUENO JOSE LUIS;POU SETO JOSEP.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA YRETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42493 , F 225, S 8, H B 180111, I/A 81(13.06.16).

11 de Diciembre de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42493 , F 225, S 8, H B 180111, I/A 80 (1.12.15).

03 de Junio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.791,67 Euros. Resultante Suscrito: 685.142,19 Euros. Modificaciones estatutarias. ART.5.RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 42493 , F 224, S 8, H B 180111, I/A 79 (25.05.15).

14 de Enero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42493 , F 224, S 8, H B 180111, I/A 78 (5.01.15).

24 de Diciembre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 197.873,66 Euros. Resultante Suscrito: 681.350,52 Euros. Otros conceptos:RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSIGUIENTES CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS.Datos registrales. T 42493 , F 224, S 8, H B 180111, I/A 77 (16.12.14).

26 de Agosto de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 342.058,95 Euros. Resultante Suscrito: 879.224,18 Euros. Modificaciones estatutarias.ART.5: RENUMERACION DE PARTICIPACIONES Y CONSIGUIENTE MODIFICACION EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS.Datos registrales. T 42493 , F 223, S 8, H B 180111, I/A 76 (18.08.14).

27 de Marzo de 2014
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: HERRANZ LOPEZ OSCAR. Datos registrales. T 42493 , F 222, S 8, H B 180111, I/A 74(20.03.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: DABAN FERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 42493 , F 222, S 8, H B 180111, I/A 75(20.03.14).

26 de Febrero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.188,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.221.283,13 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO5.-RENUMERACION DE LAS PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 42493 , F 221, S 8, H B 180111, I/A 73 (18.02.14).

17 de Enero de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5,99 Euros. Resultante Suscrito: 1.214.095,13 Euros. Otros conceptos: BAJA DE SOCIOPROFESIONAL DON CARLOS GONZALEZ ROSELL. Datos registrales. T 42493 , F 221, S 8, H B 180111, I/A 72 ( 8.01.14).

30 de Diciembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42493 , F 221, S 8, H B 180111, I/A 71(19.12.13).

20 de Diciembre de 2013
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ANNE LAURE VIARD;SANCHEZ RODRIGUEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 42493 , F 220,S 8, H B 180111, I/A 69 (13.12.13).

Revocaciones. APODERADO: TORRES RODRIGUEZ LUCIO;POLO VILLANUEVA ANTONIO TOMAS;VILLANUEVA RUIZ MARIACONCEPCION;NAVARRETE MOLINA PEDRO;CALVO RODRIGUEZ JOSE ANGEL;GONZALEZ ROSELL CARLOS;CASANOVASPARELLA IGNACIO;JUVE SANMARTI JOSE;MARIN VILANOVA JOSE MIGUEL;ROJAS MIRAVETE JOSE IGNACIO;CELADARAMOS RICARDO. Datos registrales. T 42493 , F 220, S 8, H B 180111, I/A 70 (13.12.13).

06 de Septiembre de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.813,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.185.349,12 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 28.752,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.214.101,12 Euros. Datos registrales. T 42493 , F 219, S 8, H B 180111, I/A 68(29.08.13).

07 de Mayo de 2013
Nombramientos. APODERADO: ALONSO SAN MILLAN MARTA. Datos registrales. T 42493 , F 219, S 8, H B 180111, I/A 67(25.04.13).

25 de Enero de 2013
Nombramientos. APODERADO: VILAJOANA EDUARDO DAVID. Datos registrales. T 42493 , F 218, S 8, H B 180111, I/A 66(16.01.13).

30 de Mayo de 2012
Cambio de domicilio social. CL DIPUTACIO Num.260 P.3 (BARCELONA). Datos registrales. T 42493 , F 218, S 8, H B 180111, I/A65 (21.05.12).

11 de Mayo de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 52.137,28 Euros. Resultante Suscrito: 1.201.162,72 Euros. Datos registrales. T 42493 , F217, S 8, H B 180111, I/A 64 ( 2.05.12).

21 de Marzo de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 74.993,75 Euros. Resultante Suscrito: 1.208.300,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.253.300,00 Euros. Datos registrales. T 42493 , F 216, S 8, H B 180111, I/A 63 (9.03.12).

07 de Marzo de 2012
Otros conceptos: SEPARACION DEL SOCIO PROFESIONAL LUCIO TORRES RODRIGUEZ,ADQUISICION DE UNAPARTICIPACION POR LA SOCIA PROFESIONAL OLGA ALVAREZ LLORENTE Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LATITULARIDAD DELAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 42493 , F 215, S 8, H B 180111, I/A 62 (24.02.12).

18 de Noviembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42493 , F 215, S 8, H B 180111, I/A 61 (7.11.11).

06 de Junio de 2011
Nombramientos. APODERADO: VELAZQUEZ RIVAS MARIA ISABEL. Datos registrales. T 42493 , F 214, S 8, H B 180111, I/A 60(25.05.11).

Nombramientos. APODERADO: CABODEVILA ARTIEDA MARIA PILAR. Datos registrales. T 42493 , F 214, S 8, H B 180111, I/A59 (25.05.11).

17 de Mayo de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: BUENO BUENO JOSE LUIS. SECRETARIO: BUENO BUENO JOSE LUIS. CONS.DEL.MAN: BUENOBUENO JOSE LUIS. CONSEJERO: LLONCH BARGALLO ESTEFANO. CONS.DEL.MAN: LLONCH BARGALLO ESTEFANO.CONSEJERO: POU SETO JOSEP. PRESIDENTE: POU SETO JOSEP. CONS.DEL.MAN: POU SETO JOSEP. Nombramientos.ADM.CONJUNTO: POU SETO JOSEP;BUENO BUENO JOSE LUIS. Datos registrales. T 42493 , F 213, S 8, H B 180111, I/A 57 (4.05.11).

Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ SALAZAR ALBERTO. Datos registrales. T 42493 , F 213, S 8, H B 180111, I/A 58 (4.05.11).

09 de Mayo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 41.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.178.293,75 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.283.293,75 Euros. Datos registrales. T 42493 , F 211, S 8, H B 180111, I/A 56(26.04.11).

25 de Abril de 2011
Otros conceptos: INCORPORACION DE ALBERTO MARTINEZ SALAZAR COMO NUEVO SOCIO PROFESIONAL YMODIFICACION EN LAS PARTICIPACIONES PERTENECIENTES AL SOCIO PROFESIONAL JUAN LUQUE GALA. Datosregistrales. T 41107 , F 131, S 8, H B 180111, I/A 53 (11.04.11).

Otros conceptos: INCORPORACION DE MARIA ISABEL VELAZQUEZ RIBAS COMO NUEVO SOCIO PROFESIONAL YMODIFICACION EN LAS PARTICIPACIONES PERTENECIENTES AL SOCIO PROFESIONAL CARLOS MARCOS CORRAL. Datosregistrales. T 41107 , F 131, S 8, H B 180111, I/A 54 (11.04.11).

Otros conceptos: MODIFICACION EN LAS PARTICIPACIONES PERTENECIENTES AL SOCIOPROFESIONAL CARLOSGONZALEZ ROSELL. Datos registrales. T 42493 , F 211, S 8, H B 180111, I/A 55 (11.04.11).

04 de Abril de 2011
Modificaciones estatutarias. ART.16:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 41107 , F 130, S 8, H B 180111, I/A 52 (24.03.11).

20 de Diciembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 168.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.219.543,75 Euros. Datos registrales. T 41107 , F 129, S 8,H B 180111, I/A 51 ( 7.12.10).

14 de Diciembre de 2010
Otros conceptos: MODIFICACION EN LAS PARTICIPACIONES QUE PERTENECEN AL SOCIOPROFESIONAL, LUCIO TORRESRODRIGUEZ. Datos registrales. T 41107 , F 126, S 8, H B 180111, I/A 48 (30.11.10).

Otros conceptos: ADMISION DE MARIA PILAR CABODEVILLA ARTIEDA COMO NUEVA SOCIA PROFESIONAL. Datosregistrales. T 41107 , F 127, S 8, H B 180111, I/A 49 (30.11.10).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 101.237,50 Euros. Resultante Suscrito: 1.050.793,75 Euros. Datos registrales. T 41107 ,F 128, S 8, H B 180111, I/A 50 (30.11.10).

29 de Octubre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SL. Datos registrales. T 41107 , F 126, S 8, H B 180111, I/A47 (19.10.10).

23 de Agosto de 2010
Otros conceptos: INCORPORACION COMO NUEVA SOCIA PROFESIONAL A D.OLGA ALVAREZLLORENTE Y VARIACION ENEL NUMERO DE PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 41107 , F 126, S 8, H B 180111, I/A 46 (11.08.10).

01 de Diciembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.152.031,25 Euros. Datos registrales. T 41107 , F 124, S 8,H B 180111, I/A 45 (19.11.09).

23 de Noviembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SL. Datos registrales. T 41107 , F 124, S 8, H B 180111, I/A44 (11.11.09).

14 de Mayo de 2009
Nombramientos. APODERADO: ALVAREZ LLORENTE OLGA. Datos registrales. T 41107 , F 123, S 8, H B 180111, I/A 43(30.04.09).

14 de Abril de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.107.031,25 Euros. Datos registrales. T 41107 , F 123, S 8,H B 180111, I/A 42 (31.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n