Actos BORME de Mc Cain Holding Spain Sl
31 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: MANZANO ARENAS RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO.VsecrNoConsj: RICHARD HAWRYSCH ENRIQUE. Datos registrales. T 27146 , F 117, S 8, H M 288965, I/A 18 (24.03.23).
29 de Octubre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 192.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.885.855,00 Euros. Datos registrales. T 27146 , F 117, S 8,H M 288965, I/A 17 (22.10.21).
17 de Septiembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 160.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.693.015,00 Euros. Datos registrales. T 27146 , F 116, S 8,H M 288965, I/A 16 (10.09.19).
16 de Septiembre de 2019Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 14 el nombramiento de don Andr茅s Zuluaga Henao como administrador 煤nicosiendo lo correcto consejero. Datos registrales. T 27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 14 (23.11.17).
19 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLAZA SEVILLANO PABLO. Apoderado: MOFFATT JILLIAN;AGUIRRE GARCIA LORETO;CARDOSODE MENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: PLAZA SEVILLANO PABLO;ZULUAGAHENAO ANDRES;AGUIRRE GARCIA LORETO;CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA. Apo.Sol.: PLAZASEVILLANO PABLO. Datos registrales. T 27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 15 (11.01.18).
01 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MOFFATT JILLIAN. Nombramientos. Adm. Unico: ZULUAGA HENAO ANDRES. Datosregistrales. T 27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 14 (23.11.17).
01 de Septiembre de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MCCAIN LUXEMBOURG HOLDINGS SARL. Datos registrales. T27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 13 (25.08.16).
28 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: O'BRIEN DAVID. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYORLOURENCO MARIA;O'BRIEN DAVID;SCHMIDT ANDRE;AGUIRRE GARCIA LORETO. Apoderado: CARDOSO DE MENESES DESOTTOMAYOR LOURENCO MARIA;O'BRIEN DAVID;SCHMIDT ANDRE;AGUIRRE GARCIA LORETO. Nombramientos.Consejero: MOFFATT JILLIAN. Apo.Man.Soli: PLAZA SEVILLANO PABLO. Apoderado: MOFFATT JILLIAN;AGUIRRE GARCIALORETO;CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA. Datos registrales. T 27146 , F 111, S 8, H M 288965,I/A 12 (19.10.15).
03 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA. Consejero: SHERK DARREN.Nombramientos. Consejero: AGUIRRE GARCIA LORETO;PLAZA SEVILLANO PABLO. Presidente: PLAZA SEVILLANO PABLO.Datos registrales. T 27146 , F 110, S 8, H M 288965, I/A 11 (25.11.14).
14 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHMIDT ANDRE. Nombramientos. Consejero: SHERK DARREN. Datos registrales. T 27146 , F110, S 8, H M 288965, I/A 10 (29.08.12).
02 de Agosto de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: M F HOLDINGS SARL. Datos registrales. T 27146 , F 110, S 8, H
02 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16900 , F 142, S 8, H M 288965,I/A 7 (21.01.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEXANDRE ROYO PEDRO. Presidente: ALEXANDRE ROYO PEDRO. Consejero: MC CONAGHYJEFF. Revocaciones. Apoderado: ALEXANDRE ROYO PEDRO;O'BRIEN DAVID;MC CONAGHY JEFF. Apo.Manc.: MC CONAGHYJEFF;ZILIK SARAH;BASTARACHE JULIE;JOSE RAVI;TAVERNIER GREGOIRE. Nombramientos. Consejero: CARDOSO DEMENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA;SCHMIDT ANDRE. Apo.Man.Soli: CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYORLOURENCO MARIA;O'BRIEN DAVID;SCHMIDT ANDRE;AGUIRRE GARCIA LORETO. Presidente: CARDOSO DE MENESES DESOTTOMAYOR LOURENCO MARIA. Apoderado: CARDOSO DE MENESES DE SOTTOMAYOR LOURENCO MARIA;O'BRIENDAVID;SCHMIDT ANDRE;AGUIRRE GARCIA LORETO. Datos registrales. T 16900 , F 142, S 8, H M 288965, I/A 8 (21.01.10).