Actos BORME de Mecalux Servis Sa
19 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMEZ CANTO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: CARRILLO LOSTAO JAVIER.Adm. Unico: MECALUX SA. Datos registrales. T 19185 , F 178, S 8, H M 82375, I/A 103 (13.10.23).
Nombramientos. Apoderado: CARRILLO RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 19185 , F 178, S 8, H M 82375, I/A 104(13.10.23).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MOLINA JUAN JESUS. Datos registrales. T 19185 , F 179, S 8, H M 82375, I/A 105(13.10.23).
18 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 177, S 8, H M 82375, I/A 102 (11.09.23).
23 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: CASADO PACHECO MIGUEL. Datos registrales. T 19185 , F 177, S 8, H M 82375, I/A 101 (16.08.23).
18 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: PRATS ARNAU JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 19185 , F 177, S 8, H M 82375, I/A 100(11.07.23).
03 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: ESTRADA SOLER ORIOL. Datos registrales. T 19185 , F 177, S 8, H M 82375, I/A 99 (26.10.22).
20 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: GARCIA SEGOVIA MARTA. Datos registrales. T 19185 , F 176, S 8, H M 82375, I/A 98 (13.10.22).
11 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 176, S 8, H M 82375, I/A 97 ( 4.10.22).
05 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: SANTOS DA COSTA JOAO NELSON. Datos registrales. T 19185 , F 175, S 8, H M 82375, I/A 95(28.06.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SEGOVIA MARTA. Datos registrales. T 19185 , F 175, S 8, H M 82375, I/A 96 (28.06.22).
15 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 175, S 8, H M 82375, I/A 94 ( 7.10.21).
10 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 175, S 8, H M 82375, I/A 93 (30.10.20).
01 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: CASADO PACHECO MIGUEL. Datos registrales. T 19185 , F 174, S 8, H M 82375, I/A 92 (25.05.20).
17 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: CARRILLO RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 19185 , F 173, S 8, H M 82375, I/A 91(10.12.19).
29 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 173, S 8, H M 82375, I/A 90 (22.11.19).
18 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: RUIZ DIAZ JUAN;MONTERO BETEGON LUIS ALBERTO;RECIO VILLASCLARAS JOSE-ANTONIO;CALVO LOPEZ EDUARDO;IBAÑEZ GOMEZ FERNANDO ANGEL;LORENZO VEGA JUAN ANTONIO;LEIRADO CAMPOFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 19185 , F 173, S 8, H M 82375, I/A 89 ( 5.12.18).
11 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 172, S 8, H M 82375, I/A 88 ( 4.10.18).
11 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MORENO DIAZ JULIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GOMEZ CANTO JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 19185 , F 172, S 8, H M 82375, I/A 87 ( 3.07.18).
26 de Marzo de 2018Reelecciones. Adm. Unico: MORENO DIAZ JULIAN. Datos registrales. T 19185 , F 172, S 8, H M 82375, I/A 86 (15.03.18).
02 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 172, S 8, H M 82375, I/A 85 (23.10.17).
04 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 171, S 8, H M 82375, I/A 84 (24.10.16).
19 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SANTOS DA COSTA JOAO NELSON. Datos registrales. T 19185 , F 171, S 8, H M 82375, I/A 83(11.05.16).
17 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDADAD. Cambio de objeto social. La Sociedad tienecomo objeto social la venta y montaje de estanterías y estructuras metálicas, ángulos ranurados, muebles metálicos y derivados,aunque fueren partes auxiliares, accesorias o complementarias, así como medios mecánicos destinados a movimientos ymanipulaciones logísticas, etc. Datos registrales. T 19185 , F 170, S 8, H M 82375, I/A 82 ( 9.05.16).
13 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: LEIRADO CAMPO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 19185 , F 169, S 8, H M 82375, I/A 81 (6.05.16).
10 de Noviembre de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 169, S 8, H M 82375, I/A 80 ( 2.11.15).
20 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 169, S 8, H M 82375, I/A 79 (10.10.14).
17 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: LEIRADO CAMPO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 19185 , F 169, S 8, H M 82375, I/A 78 (7.03.14).
29 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 168, S 8, H M 82375, I/A 77 (21.10.13).
06 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: FORES RAFOLS ALBERT. Datos registrales. T 19185 , F 168, S 8, H M 82375, I/A 76 (24.04.13).
01 de Febrero de 2013Reelecciones. Adm. Unico: MORENO DIAZ JULIAN. Datos registrales. T 19185 , F 168, S 8, H M 82375, I/A 75 (25.01.13).
13 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 168, S 8, H M 82375, I/A 74 ( 4.12.12).
19 de Enero de 2012Revocaciones. Apoderado: CLOFENT SUÑER GUILLEM. Datos registrales. T 19185 , F 167, S 8, H M 82375, I/A 72 ( 9.01.12).
11 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 167, S 8, H M 82375, I/A 71 (30.12.11).
16 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: CATALA MASDEU JORDI. Datos registrales. T 19185 , F 167, S 8, H M 82375, I/A 68 ( 3.11.11).
Nombramientos. Apoderado: MORENO LEONCIO MARIA ANGELES. Datos registrales. T 19185 , F 167, S 8, H M 82375, I/A 69 (3.11.11).
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CAMARERO RAFAEL. Datos registrales. T 19185 , F 167, S 8, H M 82375, I/A 70 ( 3.11.11).
23 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: CLOFENT SUÑER GUILLEM. Datos registrales. T 19185 , F 166, S 8, H M 82375, I/A 67 (10.08.11).
15 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 166, S 8, H M 82375, I/A 66 ( 2.12.10).
05 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: PUIG MOLIAS ISABEL;CLOSAS HERRERA MARIA DOLORES;CATALA MASDEU JORDI;BURGOSPASTOR LUIS-ALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: CATALA MASDEU JORDI;BURGOS PASTOR LUIS-ALBERTO;CLOSASHERRERA MARIA DOLORES;LEIRADO CAMPO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 19185 , F 165, S 8, H M 82375, I/A 65(26.01.10).
26 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 165, S 8, H M 82375, I/A 64 (13.11.09).
08 de Octubre de 2009Nombramientos. Apoderado: CARRILLO LOSTAO JAVIER. Datos registrales. T 19185 , F 164, S 8, H M 82375, I/A 62 (25.09.09).
Revocaciones. Apoderado: PUIG MOLIAS ISABEL;CLOSAS HERRERA MARIA DOLORES. Apo.Manc.: HUGUET BREA JOSEMARIA. Apoderado: CASADO PACHECO MIGUEL. Datos registrales. T 19185 , F 164, S 8, H M 82375, I/A 63 (28.09.09).
22 de Julio de 2009Revocaciones. Apoderado: PUIG MOLIAS ISABEL;CASADO PACHECO MIGUEL. Datos registrales. T 19185 , F 163, S 8, H M82375, I/A 61 (10.07.09).
11 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: PUIG MOLIAS ISABEL. Datos registrales. T 19185 , F 162, S 8, H M 82375, I/A 59 (28.04.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: PUIG MOLIAS ISABEL;CLOSAS HERRERA MARIA DOLORES;CATALA MASDEU JORDI;HUGUETBREA JOSE MARIA;BURGOS PASTOR LUIS-ALBERTO. Datos registrales. T 19185 , F 163, S 8, H M 82375, I/A 60 (28.04.09).
12 de Enero de 2009Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ JIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 19185 , F 162, S 8, H M 82375, I/A 58 (23.12.08).
05 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19185 , F 162, S 8, H M 82375, I/A 57 (18.12.08).