Actos BORME de Mecaprec Sl
01 de Junio de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.507,50 Euros. Resultante Suscrito: 62.504,00 Euros. Datos registrales. T 1056 , F 27, S8, H CA 4804, I/A 18 (24.05.23).
27 de Diciembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.010,00 Euros. Resultante Suscrito: 67.011,50 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: "Art铆culo 5.- Capital social,- El capital social se fija en SESENTA Y SIETE MIL ONCE EUROS CONCINCUENTA CENTIMOS (67.011,50), dividido en cuatrocientas cuarenta y seis (446) participaciones sociales, acumulables eindivisibles de ciento cincuenta euros con veinticinco. Datos registrales. T 1056 , F 26, S 8, H CA 4804, I/A 17 (18.12.17).
29 de Noviembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.512,50 Euros. Resultante Suscrito: 73.021,50 Euros. Datos registrales. T 1056 , F 25, S8, H CA 4804, I/A 15 (21.11.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEAL DELGADO JOSE;DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO;MARRERO GOMEZ RAMON.Secretario: MARRERO GOMEZ RAMON. Presidente: DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO. Nombramientos. Consejero:DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO;GARCIA DOMINGUEZ MANUEL ALEJANDRO;LEAL DELGADO JOSE;MARREROGOMEZ RAMON. Presidente: DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO. Secretario: MARRERO VAQUERO RAMON. Datosregistrales. T 1056 , F 26, S 8, H CA 4804, I/A 16 (21.11.17).
26 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE. Presidente: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE.Nombramientos. Presidente: DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 1056 , F 25, S 8, H CA 4804, I/A 14(19.04.16).
30 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1056 , F 24, S 8, H CA 4804, I/A 12 (19.11.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE. Presidente: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE.Consejero: GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO. Secretario: GARRIDO SANCHEZ FRANCISCO. Consejero: LEAL DELGADO JOSE.Nombramientos. Consejero: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE;LEAL DELGADO JOSE;DOMINGUEZ MILLAN CARLOSALBERTO;MARRERO GOMEZ RAMON. Presidente: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE. Secretario: MARRERO GOMEZRAMON. Datos registrales. T 1056 , F 24, S 8, H CA 4804, I/A 13 (24.11.15).
20 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ MILLAN CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 1056 , F 24, S 8, H CA 4804, I/A 11(11.08.15).
23 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARCIA CACERES MANUEL BERNABE. Datos registrales. T 1056 , F 23, S 8, H CA 4804, I/A10 (15.12.14).
23 de Abril de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.010,00 Euros. Resultante Suscrito: 80.534,00 Euros. Datos registrales. T 1056 , F 23, S8, H CA 4804, I/A 9 (14.04.09).